SUNSHARE VACATIONS LIMITED

SUNSHARE VACATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSUNSHARE VACATIONS LIMITED
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaConvertida o cerrada
    Número de empresa 02601069
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    • Actividades de agencias de viajes (79110) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TIMESHARE TRAVEL INTERNATIONAL LIMITED21 may 199121 may 1991
    CONNCO 6 LIMITED12 abr 199112 abr 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta11 ene 2015

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Misceláneos

    Forms b & z convert to rs
    2 páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Convert to rs 06/07/2016
    RES13

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 06 jul 2016

    • Capital: GBP 100,002
    3 páginasSH01

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 sept 2015

    Estado de capital el 02 sept 2015

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2015

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 sept 2014

    Estado de capital el 01 sept 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Patrick Moynihan como director el 30 jun 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Andrew Paul Lang como director el 30 jun 2014

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2014

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 sept 2013

    Estado de capital el 04 sept 2013

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Patrick Moynihan el 01 sept 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Cws (No.1) Limited el 01 sept 2013

    2 páginasCH02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2013

    3 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * 1 Angel Square Manchester M60 0AG United Kingdom* el 03 dic 2012

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* el 03 dic 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2012

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de Paul Hemingway como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Cws (No.1) Limited como director

    2 páginasAP02

    Nombramiento de Mr Patrick Moynihan como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Greenacre como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2011

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de Neil Braithwaite como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2010

    3 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    BritishAssistant Secretary45801060004
    LANG, Andrew Paul
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant170146830001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Director corporativo
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1925625
    130695310001
    CROCKER, John
    16 Hartington Road
    High Lane
    SK6 8BY Stockport
    Cheshire
    Secretario
    16 Hartington Road
    High Lane
    SK6 8BY Stockport
    Cheshire
    BritishChartered Accountant9467540001
    FITZSIMONS, Elizabeth
    24 Everett Road
    Withington
    M20 3DZ Manchester
    Lancashire
    Secretario
    24 Everett Road
    Withington
    M20 3DZ Manchester
    Lancashire
    British11723940001
    TAYLOR, Karen Ann
    18 Covent Garden
    Hillgate
    SK1 3AX Stockport
    Cheshire
    Secretario
    18 Covent Garden
    Hillgate
    SK1 3AX Stockport
    Cheshire
    British82241590001
    WHITTAKER, Katherine Alison
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    Secretario
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    British29899300002
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Director
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritishChartered Accountant87486660004
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Director
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritishChartered Accountant87486660004
    BRIERLEY, Lee David
    6 Tower View
    Belthorn
    BB1 2PD Blackburn
    Lancashire
    Director
    6 Tower View
    Belthorn
    BB1 2PD Blackburn
    Lancashire
    BritishSolicitor15056200001
    CROCKER, John
    16 Hartington Road
    High Lane
    SK6 8BY Stockport
    Cheshire
    Director
    16 Hartington Road
    High Lane
    SK6 8BY Stockport
    Cheshire
    BritishChartered Accountant9467540001
    DAWSON, Peter
    8 Culcheth Hall Farm Barns
    Withington Avenue
    WA3 4AJ Culcheth
    Cheshire
    Director
    8 Culcheth Hall Farm Barns
    Withington Avenue
    WA3 4AJ Culcheth
    Cheshire
    BritishTravel Management94606430002
    FITZSIMONS, Elizabeth
    259 Bunch Road
    West Dodsbury
    N20 8WA Manchester
    Director
    259 Bunch Road
    West Dodsbury
    N20 8WA Manchester
    BritishTrainee Solicitor35525890001
    GREENACRE, Michael David
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    Director
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    EnglandBritishGeneral Manager74808750001
    HEMINGWAY, Paul Andrew
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    Director
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    United KingdomBritishHead Of Tax And Treasury188221460001
    LOCKLEY, Kenneth Morton
    59 Prestwich Hills
    Prestwich
    M25 9PY Manchester
    Director
    59 Prestwich Hills
    Prestwich
    M25 9PY Manchester
    BritishTravel Agent47510860001
    MCPHERSON, Kenneth
    Oaklands Drive
    WA13 0NF Lymm
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Oaklands Drive
    WA13 0NF Lymm
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant224051820001
    MELLING, Christopher Eric
    21 Avonhead Close
    Horwich
    BL6 5QD Bolton
    Lancashire
    Director
    21 Avonhead Close
    Horwich
    BL6 5QD Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishHead Of Finance Travel Care58695390001
    MOYNIHAN, Patrick
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    United KingdomBritishAccountant87719730001
    NEILD, Peter David
    27 Longwood Close
    Romiley
    SK6 4LR Stockport
    Cheshire
    Director
    27 Longwood Close
    Romiley
    SK6 4LR Stockport
    Cheshire
    BritishChartered Management Accountan5032890001
    O'MALLEY, Patrick Joseph
    Flat 6 25 Old Lansdowne Road
    West Didsbury
    M20 8BP Manchester
    Director
    Flat 6 25 Old Lansdowne Road
    West Didsbury
    M20 8BP Manchester
    BritishMarketing Consultant19526740001
    PENNINGTON, Kenneth
    198 Buxton Road
    Davenport
    SK2 7AE Stockport
    Cheshire
    Director
    198 Buxton Road
    Davenport
    SK2 7AE Stockport
    Cheshire
    BritishTravel Consultant18956410001
    PERRIN, Nicholas John
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    Director
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    BritishGeneral Manager, Corporate Fin80173660001
    SEMP, Malcolm
    33 Park Lane
    Whitefield
    M45 7HL Manchester
    Director
    33 Park Lane
    Whitefield
    M45 7HL Manchester
    EnglandBritishAccountant91218510001
    SMALL, Trevor
    8 Ringley Road West
    Radcliffe
    M26 1DJ Manchester
    Lancashire
    Director
    8 Ringley Road West
    Radcliffe
    M26 1DJ Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishTravel Agent65687500002
    SPEIGHT, Andrew Jonathan
    12 Arcadia Avenue
    BH8 9ER Bournemouth
    Dorset
    Director
    12 Arcadia Avenue
    BH8 9ER Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritishTravel Agent105606860001
    WILLIAMS, Amanda Jane
    Watersedge 1 High Grove Road
    Grasscroft
    OL4 4HG Saddleworth
    Director
    Watersedge 1 High Grove Road
    Grasscroft
    OL4 4HG Saddleworth
    BritishGeneral Manager87240350002

    ¿Tiene SUNSHARE VACATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge over credit balances
    Creado el 15 jun 1998
    Entregado el 18 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The sum of £20,000.00 together with interest accrued now or to be held by the bank on account numbered 43091636.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 15 ago 1997
    Entregado el 21 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond dated 8TH august 1997 in favour of the association of british travel agents limited for £7,500
    Breve descripción
    The sum of £7,5OO together interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 29 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 17 jun 1997
    Entregado el 03 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond dated 2 september 1996 in favour of the association of british travel agents for £5,400
    Breve descripción
    £5,400 together with interest accrued now or to be held by the bank on account number 43091636.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 29 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 27 ago 1996
    Entregado el 03 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to three bonds in favour of the association of british travel agents limited for £191,935.00, £5,400.00 and £65,004.00 respectively
    Breve descripción
    The sum of £262,339 together with interest held by the bank on an account numbered 43091636 and designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 29 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 19 jul 1996
    Entregado el 30 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to 3 bonds in favour of the association of british travel agents for £191,135 £5,000 and £65004
    Breve descripción
    The sum of £261,939 together with interest accrued now or to be held by the bank on account no:-43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 30 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 29 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 29 nov 1995
    Entregado el 06 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to two bonds in favour of the association of british travel agents limited for £191,935 and £5,000
    Breve descripción
    The sum of £196,935 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 29 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 04 ago 1995
    Entregado el 10 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to three bonds in favour of the association of british travel agents for £20,000 £156,600 and £10,000 respectively
    Breve descripción
    The sum of £186,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 43091636.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ago 1995Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 09 ene 1995
    Entregado el 13 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to two bonds in favour of the association of british travel agents limited for £20,000 and £156,600
    Breve descripción
    The sum of £176,600 together with the interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 30 ago 1994
    Entregado el 14 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to two bonds in favour of the association of british travel agents limited for £20,000 and £70,239
    Breve descripción
    The sum of £90,239 together with interest accrued now or to be held by nationalwestminster bank PLC on account numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 18 jul 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 29 abr 1994
    Entregado el 13 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of the association of british travel agents limited for £10,000
    Breve descripción
    The sum of £10,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an acount numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 18 jul 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Memorandum of cash deposit
    Creado el 13 ene 1994
    Entregado el 15 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The sum of £40,239 credited to account number/designation 13128663 with the bank together with all sums in the future credited to that account and including all interest accrued or accruing in the future on the account.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0