TEREX LIFTING U.K. LIMITED

TEREX LIFTING U.K. LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTEREX LIFTING U.K. LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02602451
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    • fabricación de equipos de elevación y manipulación (28220) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MATBRO LIMITED16 ago 199116 ago 1991
    FORAY 292 LIMITED17 abr 199117 abr 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 29 jun 2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 23 jun 2017

    • Capital: GBP 2,500,003
    3 páginasSH01

    Declaración de confirmación presentada el 17 abr 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de John Daniel Sheehan como director el 27 feb 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kevin Patrick Bradley como director el 27 feb 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 abr 2016

    Estado de capital el 25 abr 2016

    • Capital: GBP 2,500,002
    SH01

    Cese del nombramiento de Ronald Matthew Defeo como director el 11 dic 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 abr 2015

    Estado de capital el 17 abr 2015

    • Capital: GBP 2,500,002
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 abr 2014

    Estado de capital el 28 abr 2014

    • Capital: GBP 2,500,002
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Kevin Patrick Bradley como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Phillip Widman como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Ronald Matthew Defeo el 17 abr 2012

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    Secretario
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    American65582430009
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    Director
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    United StatesAmerican65582430009
    SHEEHAN, John Daniel
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    Usa
    Director
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    Usa
    United StatesAmerican226001330001
    BROOKES, Howard Maurice
    14 Ryknild Close
    Four Oaks
    B74 4UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretario
    14 Ryknild Close
    Four Oaks
    B74 4UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British662930001
    HARRIS, Andrew David
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    Secretario
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    British47665710002
    MANDERS, Douglas Nigel
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    Secretario designado
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    British900003700001
    APUZZO, Joseph
    190 Sturges Ridge Road
    Wilton
    Fairfield
    06897
    Usa
    Director
    190 Sturges Ridge Road
    Wilton
    Fairfield
    06897
    Usa
    American66269020001
    BAILLIE, Fergus Cumming
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    Director
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    British924340002
    BRADLEY, Kevin Patrick
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    United Kingdom
    Director
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    United Kingdom
    Untied States Of AmericaAmerican176590390001
    COSGROVE, Barry
    11 Adair Avenue
    BT80 8PU Cookstown
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Director
    11 Adair Avenue
    BT80 8PU Cookstown
    County Tyrone
    Northern Ireland
    British13991920001
    CRAIG, John Egwin
    Saxonbury House
    Frant
    TN3 9HJ Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Saxonbury House
    Frant
    TN3 9HJ Tunbridge Wells
    Kent
    British15697900001
    DEFEO, Ronald Matthew
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    Director
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    United StatesAmerican94656950001
    DOOEY, Hugh Pat
    14 Usnastraine Road
    BT71 5DE Coalisland
    Tyrone
    N Ireland
    Director
    14 Usnastraine Road
    BT71 5DE Coalisland
    Tyrone
    N Ireland
    Northern IrelandIrish115095900001
    HARRIS, Andrew David
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    Director
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    British47665710002
    HARRIS, Andrew David
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    Director
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    British47665710002
    HOLMES, Edward
    Rushford House Rushford Bridge
    GL12 8JW Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Director
    Rushford House Rushford Bridge
    GL12 8JW Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British55964730001
    KENNERLEY, John Frank William
    Old Westwick
    Chantry View Road
    GU1 3XW Guildford
    Surrey
    Director
    Old Westwick
    Chantry View Road
    GU1 3XW Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish69793560001
    MANDERS, Douglas Nigel
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    Director designado
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    British900003700001
    MCGRATH, Brendan
    13 Newent Close
    Winyates Green
    B98 0QW Redditch
    Worcestershire
    Director
    13 Newent Close
    Winyates Green
    B98 0QW Redditch
    Worcestershire
    Irish38927470001
    MCKEOWN, Shay
    41 Tullycullion Road
    Dungannon
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Director
    41 Tullycullion Road
    Dungannon
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Irish40247040001
    MURCHAN, Seamus Michael
    2 Ferndale
    Clonallon Road
    BT34 3FE Warrenpoint
    County Down
    Director
    2 Ferndale
    Clonallon Road
    BT34 3FE Warrenpoint
    County Down
    Northern IrelandNorthern Irish182530670001
    NICHOLSON SMITH, James Timothy
    Kings Farm
    Stockwell Lane, Woodmancote
    GL52 4QB Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Kings Farm
    Stockwell Lane, Woodmancote
    GL52 4QB Cheltenham
    Gloucestershire
    British70851540001
    NOONE, Liam
    121 Malmesbury Road
    SN15 1PZ Chippenham
    Wiltshire
    Director
    121 Malmesbury Road
    SN15 1PZ Chippenham
    Wiltshire
    Irish47114340001
    REES, Andrew Merfyn
    114 Vivian Road
    Harborne
    B17 0DJ Birmingham
    West Midlands
    Director
    114 Vivian Road
    Harborne
    B17 0DJ Birmingham
    West Midlands
    British3425330001
    RICE, Michael Joseph
    The Street
    GL9 1HH Acton Turville
    Greenfields
    Gloucestershire
    Director
    The Street
    GL9 1HH Acton Turville
    Greenfields
    Gloucestershire
    United KingdomBritish140087640001
    ROBERTSON, Colin
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    Director
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    British77076440001
    WATSON, Hubert John
    20 Victoria Grove
    Dollingstown Lurgan
    BT66 7JJ Craigavon
    County Armagh
    Director
    20 Victoria Grove
    Dollingstown Lurgan
    BT66 7JJ Craigavon
    County Armagh
    British56996050003
    WIDMAN, Phillip Charles
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    Director
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    UsaAmerican144249950001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    England
    06 abr 2016
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03720364
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene TEREX LIFTING U.K. LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed charge on book and other debts
    Creado el 16 may 2002
    Entregado el 23 may 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all book debts and other debts.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 23 may 2002Registro de un cargo (395)
    Composite debenture
    Creado el 04 mar 1999
    Entregado el 25 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 25 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite debenture
    Creado el 04 mar 1999
    Entregado el 25 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 25 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite debenture
    Creado el 04 mar 1999
    Entregado el 25 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Allied Irish Banks PLC
    Transacciones
    • 25 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite debenture
    Creado el 04 mar 1999
    Entregado el 25 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Smurfit Paribas Bank Limited
    Transacciones
    • 25 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite debenture
    Creado el 04 mar 1999
    Entregado el 25 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland,as Security Trustee for the Secured Parties(As Defined)
    Transacciones
    • 25 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite debenture
    Creado el 26 mar 1998
    Entregado el 16 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the governor and company of the bank of ireland as security trustee for the banks ("the secured parties") all monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them whether collectively or individually by the company either alone or jointly with any person or company on any account under the terms and conditions as defined in the composite debenture
    Breve descripción
    A fixed charge over all the companys f/h and l/h lands hereditaments, premises, property and chattels both present and future including the property particulars of which are specified under the company's name in the second schedule hereto and all the company's interests in all buildings, fixtures (including, without limitation, trade fixtures) and the fixed plant and machinery from time to time thereon; all present and future plant machinery vehicles fixtures implements utensils and equipment, all goodwill and uncalled capital and all debts; floating charge over the book debts undertaking and all other property assets and rights whatsoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Irelandas Security Trustee for the Banks ("the Securedparties")
    Transacciones
    • 16 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0