JOHN BROWN DIGITAL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | JOHN BROWN DIGITAL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02603954 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de JOHN BROWN DIGITAL LIMITED?
- Otras actividades editoriales (58190) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra JOHN BROWN DIGITAL LIMITED?
| Dirección de la sede social | 10 Triton Street Regent's Place NW1 3BF London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JOHN BROWN DIGITAL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| JOHN BROWN COMMUNICATIONS LIMITED | 04 nov 2008 | 04 nov 2008 |
| FINGAL LIMITED | 12 ago 2005 | 12 ago 2005 |
| MPA FINGAL LIMITED | 03 dic 1991 | 03 dic 1991 |
| LAW 377 LIMITED | 23 abr 1991 | 23 abr 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de JOHN BROWN DIGITAL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para JOHN BROWN DIGITAL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 21 may 2021
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 026039540007 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2019 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 35 páginas | MA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Dennis Romijn como director el 22 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Scott Morris como director el 22 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicholas Paul Waters como director el 22 jul 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Mark Hirsch como director el 22 jul 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Moberly como secretario el 29 feb 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nicholas Paul Waters como director el 26 jun 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Alexander Robert Connelly como director el 04 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Alexander Robert Connelly como director el 06 jul 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Gordon Creighton como director el 10 jul 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mary Margaret Basterfield como director el 09 feb 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Gordon Creighton como director el 04 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de JOHN BROWN DIGITAL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRIS, James Scott | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | England | British | 212771730001 | |||||
| ROMIJN, Dennis | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | Netherlands | Dutch | 272475570001 | |||||
| CAMPKIN, Christopher John | Secretario | 86 Elthorne Park Road W7 2JD London | British | 78308230002 | ||||||
| CARTER, Matthew Robert | Secretario | 30 Carminia Road Tooting SW17 8AH London | British | 20035200001 | ||||||
| FITZPATRICK, Dean Marvin | Secretario | 26 Cranbourne Road N10 2BT London | British | 81553650001 | ||||||
| MOBERLY, Andrew John | Secretario | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | 205299850001 | |||||||
| SILCOX, Alex David | Secretario | 136-142 Bramley Road London W10 6SR | 175851560001 | |||||||
| CLP COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | Fifth Floor 99 Charterhouse Street EC1M 6NQ London | 75589480001 | |||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | Carmelite 50 Victoria Embankment EC4Y 0DX Blackfriars London | 41864110001 | |||||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Secretario designado corporativo | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 | |||||||
| SECRETARIAL SOLUTIONS LIMITED | Secretario corporativo | 5 Old Bailey EC4M 7JX London | 81435090006 | |||||||
| BASTERFIELD, Mary Margaret | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | United Kingdom | British | 295094520001 | |||||
| BROWN, John Dominic Weare | Director | 120 Elgin Crescent W11 2JL London | United Kingdom | British | 35549390002 | |||||
| CAMPKIN, Christopher John | Director | 86 Elthorne Park Road W7 2JD London | Great Britain | British | 78308230002 | |||||
| CARTER, Matthew Robert | Director | 30 Carminia Road Tooting SW17 8AH London | United Kingdom | British | 20035200001 | |||||
| CLARK, Gavin Nicholas | Director | 6 Gilstead Road SW6 2LG London | British | 102237050001 | ||||||
| CLARKSON, Jeremy Charles Robert | Director | 31 Forth Bridge Road Wandsworth SW11 London | British | 30274050002 | ||||||
| CONNELLY, James Alexander Robert | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | England | British | 202477130001 | |||||
| CREIGHTON, Mark Gordon | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | United Kingdom | British | 257075000001 | |||||
| DE GROOSE, Tracy Anne | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 England | England | British | 171412510001 | |||||
| FITZPATRICK, Dean Marvin | Director | 26 Cranbourne Road N10 2BT London | England | British | 81553650001 | |||||
| GILL, Jonathan Arthur Compton | Director | 3 Bowerdean Street Fulham SW6 3TN London | England | British | 35120590002 | |||||
| HIRSCH, Andrew Mark | Director | 64 Parliament Hill NW3 2TL London | England | British | 107066560001 | |||||
| JAGO, Francis Hilary | Director | 58 Thurleigh Road SW12 8UD London | British | 62496130002 | ||||||
| JAGO, Francis Hilary | Director | 31 Osward Road SW17 7SS London | British | 62496130001 | ||||||
| KAY, Elizabeth | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 England | England | British | 176507210001 | |||||
| PRICE, Claire Margaret | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 England | England | British | 181956820001 | |||||
| SILCOX, Alexander David | Director | 136-142 Bramley Road London W10 6SR | England | British | 186834220001 | |||||
| SOHI, Kashmir Singh | Director | Bramley Road W10 6SR London 136-142 England | England | British | 45116130003 | |||||
| STEVENS, Geoffrey Robert | Director | Beech House 3 Millhouses Court S11 9HZ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 57380020001 | |||||
| TEE, Deborah Jane | Director | High Barn High Barn Road KT24 5PR Effingham Surrey | United Kingdom | British | 80612160001 | |||||
| WATERS, Nick Paul | Director | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | England | British | 279380860001 | |||||
| HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900008160001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de JOHN BROWN DIGITAL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Brown Magazines Limited | 06 abr 2016 | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene JOHN BROWN DIGITAL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 14 may 2015 Entregado el 19 may 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of accession to guarantee and debenture | Creado el 27 abr 2007 Entregado el 16 may 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 18 nov 2004 Entregado el 20 nov 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 25 ene 2002 Entregado el 05 feb 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £68,297.00 due from the company to the chargee | |
Breve descripción Monies held pursuant to the rent deposit deed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 15 abr 1996 Entregado el 04 may 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 18 dic 1991 Entregado el 24 dic 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción See doc M167C for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 17 dic 1991 Entregado el 02 ene 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Heathmans house,19 heathmans road,london. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0