NEXVALE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNEXVALE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02604384
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NEXVALE LIMITED?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra NEXVALE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NEXVALE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEXVALE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 abr 2012

    Estado de capital el 19 abr 2012

    • Capital: GBP 115,600
    SH01

    Nombramiento de Jonathan David Calow como secretario el 08 dic 2011

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Care Uk Services Limited como secretario el 08 dic 2011

    1 páginasTM02

    second-filing-of-form-with-form-type

    9 páginasRP04
    Anotaciones
    FechaAnotación
    27 oct 2011Clarification A second filed AP01 for Dr Alison Rose-Quirie was registered on 27/10/2011.

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    9 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Care Uk Services Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Nombramiento de Dr Alison Jane Rose-Quirie como director

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    27 oct 2011Clarification A second filed AP01 for Dr Alison Rose-Quirie was registered on 27/10/2011.

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Domicilio social registrado cambiado de 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR el 08 feb 2011

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Michael Robert Parish como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Paul Justin Humphreys como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Joan Dawson como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Eberhard Vonwick como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Christopher Robert Brown como director

    2 páginasAP01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 abr 2011 au 30 sept 2011

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 01 abr 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 abr 2010

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 abr 2009

    6 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de NEXVALE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CALOW, Jonathan David
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secretario
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    165501240001
    BROWN, Christopher Robert
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Director
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish138821850001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Director
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish33223550003
    PARISH, Michael Robert
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Director
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish78828750003
    ROSE-QUIRIE, Alison Jane, Dr
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Director
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish190407640001
    HARRISON, Elizabeth
    18 Cranford Road
    DA1 1JP Dartford
    Kent
    Secretario
    18 Cranford Road
    DA1 1JP Dartford
    Kent
    British27588290001
    VONWICK, Eberhard
    Totteridge Green
    N20 8PA London
    The Old House
    Secretario
    Totteridge Green
    N20 8PA London
    The Old House
    Other134818370001
    CARE UK SERVICES LIMITED
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro02482660
    157793350001
    SEMKEN LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    Secretario designado corporativo
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    900005970001
    DAWSON, Joan Denise
    Rhodes Farm The Ridgeway
    Mill Hill
    NW7 1RH London
    Director
    Rhodes Farm The Ridgeway
    Mill Hill
    NW7 1RH London
    British29462760001
    LUFMER LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    Director designado corporativo
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    900005960001

    ¿Tiene NEXVALE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 21 jul 2005
    Entregado el 22 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 21 jul 2005
    Entregado el 22 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Property k/a rhodes farm and the land at the back, the ridgeway, mill hill, london t/n ngl 320196 and ngl 709975. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 08 jul 1991
    Entregado el 19 jul 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (See 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 jul 1991Registro de una carga
    • 07 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0