PALADIN (FORMER SUBSIDIARY) LIMITED

PALADIN (FORMER SUBSIDIARY) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPALADIN (FORMER SUBSIDIARY) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02610912
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PALADIN (FORMER SUBSIDIARY) LIMITED?

    • Instalación eléctrica (43210) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra PALADIN (FORMER SUBSIDIARY) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    305 Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PALADIN (FORMER SUBSIDIARY) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CALBARRIE LIMITED15 may 199115 may 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PALADIN (FORMER SUBSIDIARY) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PALADIN (FORMER SUBSIDIARY) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Nombramiento de Mr David Cowans como director el 16 nov 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Christopher Robin Leslie Phillips como director el 16 nov 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Roxburgh Milkins Llp como secretario el 16 nov 2012

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de 2 Crescent Office Park Clarks Way Bath BA2 2AF el 03 dic 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 15 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 jun 2012

    Estado de capital el 13 jun 2012

    • Capital: GBP 150
    SH01

    legacy

    3 páginasMG04

    legacy

    3 páginasMG04

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 17 ene 2012

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cese del nombramiento de Ian Richard Panter como director el 17 ene 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Leslie Anthony Bayliss como director el 17 ene 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael Conyers como director el 17 ene 2012

    1 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    23 páginasAA

    legacy

    12 páginasMG01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Estado de capital el 09 jun 2011

    • Capital: GBP 150
    4 páginasSH19

    ¿Quiénes son los directivos de PALADIN (FORMER SUBSIDIARY) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COWANS, David
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    Director
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director108543490005
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    Greenfield Drive
    N2 9AF London
    17
    United Kingdom
    Director
    Greenfield Drive
    N2 9AF London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritishChairman46176700002
    SAUNDERS, Timothy
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    Director
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director47952140001
    HOLLINGWORTH, Sally Eleanor
    82 Village Road
    Bromham
    MK43 8LJ Bedford
    Bedfordshire
    Secretario
    82 Village Road
    Bromham
    MK43 8LJ Bedford
    Bedfordshire
    British8498370001
    SAUNDERS, Timothy
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Secretario
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    BritishCompany Director47952140001
    MBC SECRETARIES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Secretario designado corporativo
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000700001
    REID & CO PROFESSIONAL SERVICES LIMITED
    Witan Court
    305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secretario corporativo
    Witan Court
    305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    41052090008
    ROXBURGH MILKINS LLP
    Merchants House North
    Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    Secretario corporativo
    Merchants House North
    Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    114974370003
    BAYLISS, John Leslie Anthony
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Director
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    United KingdomBritishManaging Director96980070002
    BUSTIN, Desmond John
    West Charleton Grange
    West Charleton
    TQ7 2AD Kingsbridge
    Devon
    Director
    West Charleton Grange
    West Charleton
    TQ7 2AD Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritishCompany Director31260040004
    CHAMPION, Mark Alistair
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Director
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    EnglandBritishDirector76512840002
    CONYERS, Michael
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Director
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    EnglandBritishDirector97801350001
    HOLLINGWORTH, Neil Gregory
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    Director
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    United KingdomBritishDirector87647990001
    PANTER, Ian Richard
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Director
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    BritishDirector123070490001
    WRIGHT, Barry
    52 Fulmar Road
    Brickhill
    MK41 7JZ Bedford
    Bedfordshire
    Director
    52 Fulmar Road
    Brickhill
    MK41 7JZ Bedford
    Bedfordshire
    BritishElectronics Engineer21688480002
    MBC NOMINEES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Director designado corporativo
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000690001

    ¿Tiene PALADIN (FORMER SUBSIDIARY) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 10 jun 2011
    Entregado el 15 jun 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Nvm Private Equity Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 15 jun 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 02 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 13 feb 2008
    Entregado el 21 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Nvm Private Equity Limited
    Transacciones
    • 21 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 27 jun 2006
    Entregado el 13 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Neil Gregory Hollingworth
    • Neil Gregory Hollingworth
    Transacciones
    • 13 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 29 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Assignment of intellectual property rights
    Creado el 27 jun 2006
    Entregado el 11 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The company assigned to the bank all the company's right title and interest in and to the intellectual property rights throughout the world excluding the third party rights and all applications and all the company's rights title and interest in and to the applications. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 20 ene 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 02 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 27 jun 2006
    Entregado el 11 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 20 ene 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 02 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 27 jun 2006
    Entregado el 30 jun 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Northern Venture Managers Limited
    Transacciones
    • 30 jun 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 12 may 2003
    Entregado el 30 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 30 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 21 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 abr 1992
    Entregado el 13 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 17 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0