KENWICK ESTATES LIMITED

KENWICK ESTATES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKENWICK ESTATES LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02616643
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KENWICK ESTATES LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra KENWICK ESTATES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Maylands Building
    200 Maylands Avenue
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KENWICK ESTATES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FLYNN & MONCASTER LIMITED29 may 199129 may 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KENWICK ESTATES LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para KENWICK ESTATES LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta29 may 2025
    Próxima declaración de confirmación vence12 jun 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta29 may 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KENWICK ESTATES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Resoluciones

    Resolutions
    33 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Resoluciones

    Resolutions
    33 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Mr Simon Edward Jones como director el 15 ene 2025

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Greg Lashley el 15 jul 2024

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Greg Lashley el 15 jul 2024

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 29 may 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023

    5 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Carl Anthony Castledine el 19 nov 2023

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Neill Timothy Ryder como director el 19 jun 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 29 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    5 páginasAA

    Modification des détails de Coppergreen Developments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 sept 2022

    2 páginasPSC05

    Cambio de datos del director Mr Neill Timothy Ryder el 21 sept 2022

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Greg Lashley el 21 sept 2022

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Carl Anthony Castledine el 21 sept 2022

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Beeley House Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex Station Road Sheffield S36 2UZ England a The Maylands Building 200 Maylands Avenue Hemel Hempstead HP2 7TG el 22 sept 2022

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 29 may 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de David Copley como director el 11 mar 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sharon Samantha Jacqueline Wall como director el 11 mar 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Donna Copley como director el 11 mar 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Marcel Sidi como director el 11 mar 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Neill Timothy Ryder como director el 20 ene 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Greg Lashley como director el 20 ene 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Carl Castledine como director el 20 ene 2022

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de KENWICK ESTATES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CASTLEDINE, Carl Anthony
    200 Maylands Avenue
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    The Maylands Building
    England
    Director
    200 Maylands Avenue
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    The Maylands Building
    England
    EnglandBritishDirector147272430002
    JONES, Simon Edward
    200 Maylands Avenue
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    The Maylands Building
    England
    Director
    200 Maylands Avenue
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    The Maylands Building
    England
    United KingdomBritishDirector201568280001
    LASHLEY, Greg
    200 Maylands Avenue
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    The Maylands Building
    England
    Director
    200 Maylands Avenue
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    The Maylands Building
    England
    United KingdomBritishDirector127168690004
    ATKINSON, John Alexander Lovel
    York House High Street
    Blyth
    S81 8EQ Worksop
    Nottinghamshire
    Secretario
    York House High Street
    Blyth
    S81 8EQ Worksop
    Nottinghamshire
    British19348000001
    FLYNN, Sylvia
    99 Horncastle Road
    LN11 9QT Louth
    Lincolnshire
    Secretario
    99 Horncastle Road
    LN11 9QT Louth
    Lincolnshire
    BritishCompany Director38405090002
    MONCASTER, Betty
    The Moorings Mill Lane
    Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Secretario
    The Moorings Mill Lane
    Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    BritishDirector4677130001
    BROWN, Stephen John Thursfield
    Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex
    Station Road
    S36 2UZ Sheffield
    Beeley House
    England
    Director
    Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex
    Station Road
    S36 2UZ Sheffield
    Beeley House
    England
    EnglandBritishDirector17541670001
    COPLEY, David
    Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex
    Station Road
    S36 2UZ Sheffield
    Beeley House
    England
    Director
    Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex
    Station Road
    S36 2UZ Sheffield
    Beeley House
    England
    EnglandBritishDirector106772790001
    COPLEY, Donna
    Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex
    Station Road
    S36 2UZ Sheffield
    Beeley House
    England
    Director
    Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex
    Station Road
    S36 2UZ Sheffield
    Beeley House
    England
    EnglandBritishDirector116313780001
    DREDGE, Martin
    3 Huddersfield Road
    Honley
    HD9 6PE Holmfirth
    West Yorkshire
    Director
    3 Huddersfield Road
    Honley
    HD9 6PE Holmfirth
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director92645220001
    FLYNN, Stuart David
    99 Horncastle Road
    LN11 9QT Louth
    Lincolnshire
    Director
    99 Horncastle Road
    LN11 9QT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritishCompany Director40587230001
    FLYNN, Sylvia
    99 Horncastle Road
    LN11 9QT Louth
    Lincolnshire
    Director
    99 Horncastle Road
    LN11 9QT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritishDirector38405090002
    MONCASTER, Betty
    The Moorings Mill Lane
    Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Director
    The Moorings Mill Lane
    Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    BritishCompany Director4677130001
    RYDER, Neill Timothy
    200 Maylands Avenue
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    The Maylands Building
    England
    Director
    200 Maylands Avenue
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    The Maylands Building
    England
    EnglandBritishCfo102418720002
    SIDI, Richard Marcel
    Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex
    Station Road
    S36 2UZ Sheffield
    Beeley House
    England
    Director
    Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex
    Station Road
    S36 2UZ Sheffield
    Beeley House
    England
    United KingdomBritishDirector111396900002
    WALL, Sharon Samantha Jacqueline
    Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex
    Station Road
    S36 2UZ Sheffield
    Beeley House
    England
    Director
    Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex
    Station Road
    S36 2UZ Sheffield
    Beeley House
    England
    EnglandBritishDirector176314320001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KENWICK ESTATES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    200 Maylands Avenue
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    The Maylands Building
    England
    31 jul 2018
    200 Maylands Avenue
    HP2 7TG Hemel Hempstead
    The Maylands Building
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06434179
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Mr Stuart David Flynn
    Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex
    Station Road
    S36 2UZ Sheffield
    Beeley House
    England
    06 abr 2016
    Unit 26 Wharncliffe Industrial Complex
    Station Road
    S36 2UZ Sheffield
    Beeley House
    England
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene KENWICK ESTATES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 31 jul 2018
    Entregado el 06 ago 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    The property known as kenwick park estate, louth, lincolnshire and registered at hm land registry with title numbers LL101598, LL181268 and LL181140.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 2018Registro de una carga (MR01)
    • 28 ene 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 31 jul 2018
    Entregado el 06 ago 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    A fixed and floating charge over all assets.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 2018Registro de una carga (MR01)
    • 28 ene 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 07 ene 2005
    Entregado el 14 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at south winchester golf club pitt winchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 29 ago 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 25 nov 2003
    Entregado el 05 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £80,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The property being jenny wood kenwick park louth lincolnshire.
    Personas con derecho
    • John Bernard Morton and Patricia Irene Morton
    Transacciones
    • 05 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 nov 2003
    Entregado el 05 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at jenny wood kenwick park louth lincolnshire and land adjoining t/n LL181268 & t/n LL18114O. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 23 sept 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 01 ago 2002
    Entregado el 08 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 sept 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 01 ago 2002
    Entregado el 06 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land lying to the south 9F kenwick hill legbourne lincolnshire t/n LL101598. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 sept 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 02 dic 1991
    Entregado el 12 dic 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a and being part of kewick park estae louth lincolnshire with the buildings thereon which forms part of title no: LL46324.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 dic 1991Registro de un cargo (395)
    • 02 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 dic 1991
    Entregado el 07 dic 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade and tenants fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 dic 1991Registro de un cargo (395)
    • 29 ene 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0