SYSTEMCARE MARKETING LIMITED

SYSTEMCARE MARKETING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSYSTEMCARE MARKETING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02619054
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SYSTEMCARE MARKETING LIMITED?

    • (7222) /

    ¿Dónde se encuentra SYSTEMCARE MARKETING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    99 Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    Uk
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SYSTEMCARE MARKETING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CONTRACT COMPUTER SUPPLIES LIMITED28 ago 199128 ago 1991
    KALL SUPPLIES LIMITED29 jul 199129 jul 1991
    SERVEPULSE LIMITED11 jun 199111 jun 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SYSTEMCARE MARKETING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SYSTEMCARE MARKETING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 11 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 jul 2010

    Estado de capital el 12 jul 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cambio de datos del director Edward Ufland el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Giles Hudson el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Ola Tricia Aramita Barreto-Morley el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario S & J Registrars Limited el 01 oct 2009

    2 páginasCH04

    Cese del nombramiento de Gavin Udall como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Philip Matthew Deakin como director

    2 páginasAP01

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2008

    15 páginasAA

    legacy

    1 páginas403a

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas225

    legacy

    11 páginas288a

    legacy

    11 páginas288a

    legacy

    11 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de SYSTEMCARE MARKETING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Floor 99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    5th
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor 99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    5th
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro01740543
    132600000001
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Director
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    United KingdomBritishTax Manager140644240001
    DEAKIN, Philip Matthew
    Wellington Court
    Spencers Wood
    RG7 1BN Reading
    12
    Berkshire
    Director
    Wellington Court
    Spencers Wood
    RG7 1BN Reading
    12
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant146225080002
    HUDSON, Giles Matthew
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Director
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    United KingdomBritishChartered Accountant161583790001
    UFLAND, Edward
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Director
    Gresham Street
    Fifth Floor
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    United KingdomBritishChartered Accountant87558180001
    BURNHOPE, Mark Edward
    113 Stafford Road
    Bloxwich
    WS3 3PG Walsall
    West Midlands
    Secretario
    113 Stafford Road
    Bloxwich
    WS3 3PG Walsall
    West Midlands
    English60709550001
    MAYBURY, Linda
    29 Pensford Road
    Northfield
    B31 3AG Birmingham
    West Midlands
    Secretario
    29 Pensford Road
    Northfield
    B31 3AG Birmingham
    West Midlands
    British19976750001
    REX, Simon John
    Cooden Cottage 57 Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UJ Worcester
    Worcestershire
    Secretario
    Cooden Cottage 57 Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UJ Worcester
    Worcestershire
    British11273460001
    STUBBS, Elspeth Anne
    Keats House 50 Station Road
    HP9 1AB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secretario
    Keats House 50 Station Road
    HP9 1AB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British25311820001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BURNHOPE, Mark Edward
    113 Stafford Road
    Bloxwich
    WS3 3PG Walsall
    West Midlands
    Director
    113 Stafford Road
    Bloxwich
    WS3 3PG Walsall
    West Midlands
    EnglandEnglishDirector60709550001
    MCKAY, Michael William Hoy
    Peggs Farm
    Orton On The Hill
    CV9 3NE Atherstone
    Warwickshire
    Director
    Peggs Farm
    Orton On The Hill
    CV9 3NE Atherstone
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director53050860001
    REX, Simon John
    Cooden Cottage 57 Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UJ Worcester
    Worcestershire
    Director
    Cooden Cottage 57 Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UJ Worcester
    Worcestershire
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)BritishDirector11273460001
    REX, Simon John
    Cooden Cottage 57 Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UJ Worcester
    Worcestershire
    Director
    Cooden Cottage 57 Station Road
    Fernhill Heath
    WR3 7UJ Worcester
    Worcestershire
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)BritishCompany Director11273460001
    SHAW, John William
    Old Hunting Lodge Worcester Road
    Great Witley
    WR6 6JT Worcester
    Director
    Old Hunting Lodge Worcester Road
    Great Witley
    WR6 6JT Worcester
    United KingdomBritishDirector61198560001
    SKEGGS, Douglas Frederick
    Tre Ribble Barn
    HR2 8LS Three Ashes
    Herefordshire
    Director
    Tre Ribble Barn
    HR2 8LS Three Ashes
    Herefordshire
    EnglandBritishCompany Director156791110001
    STUBBS, Kenneth Thomas
    Keats House 50 Station Road
    HP9 1AB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Keats House 50 Station Road
    HP9 1AB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director25311810001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishAccountant83889580001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene SYSTEMCARE MARKETING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 03 dic 2004
    Entregado el 16 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 09 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 feb 2001
    Entregado el 20 feb 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 20 feb 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 nov 1995
    Entregado el 06 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 07 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 sept 1991
    Entregado el 16 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 sept 1991Registro de una carga
    • 07 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0