AMEC PROJECT INVESTMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | AMEC PROJECT INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02619408 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AMEC PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra AMEC PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Booths Park Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Cheshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AMEC PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| AMEC POWER (HS) PENSIONS TRUSTEE LIMITED | 31 ene 1992 | 31 ene 1992 |
| JAMES SCOTT POWER (HS) PENSIONS TRUSTEE LIMITED | 25 jun 1991 | 25 jun 1991 |
| ALNERY NO. 1090 LIMITED | 11 jun 1991 | 11 jun 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AMEC PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para AMEC PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 08 jun 2024 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AMEC PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Grant Rae Angus como director el 01 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William George Setter como director el 21 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 18 feb 2025
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2023 | 16 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 261 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Nombramiento de Mr William George Setter como director el 31 ago 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Stuart Mclean como director el 31 ago 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr William Charles Guy Abbott como director el 22 jul 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Nigel Plant como director el 22 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Sarah Marion Macrury como secretario el 22 jul 2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Iain Angus Jones como secretario el 12 jun 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Matthew Nigel Plant el 30 nov 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew Stuart Mclean el 30 nov 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Iain Angus Jones el 30 nov 2023 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2022 | 18 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 261 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de AMEC PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACRURY, Sarah Marion | Secretario | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | 325356990001 | |||||||
| ABBOTT, William Charles Guy | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | United Kingdom | British | 325357240001 | |||||
| ANGUS, Grant Rae | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | Scotland | British | 197743170001 | |||||
| FELLOWES, Colin | Secretario | 9 Thistlewood Drive Summerfields SK9 2RF Wilmslow Cheshire | British | 800670001 | ||||||
| FIDLER, Christopher Laskey | Secretario | Marlborough Avenue SK8 7AW Cheadle Hulme 66 Cheshire | British | 141025870003 | ||||||
| JONES, Iain Angus | Secretario | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | 244678200001 | |||||||
| TABERNER, Susan | Secretario | 9 Hillside BL1 5DT Bolton Lancashire | British | 96933410001 | ||||||
| WARBURTON, Jennifer Ann | Secretario | Booths Park Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Cheshire | 214812320001 | |||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Secretario designado corporativo | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
| AMEC NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | Sandiway House Hartford CW8 2YA Northwich Cheshire | 32732300001 | |||||||
| BARDSLEY, Michael John | Director | 7 Downs End WA16 8BQ Knutsford Cheshire England | British | 34847060001 | ||||||
| BATEMAN, Charles Ian | Director | "Dalewood" 586 Chester Road Sandiway CW8 2DX Northwich Cheshire | British | 1128650001 | ||||||
| BELL, Leslie Anthony | Director | 25 Cambridge Road PR9 9NQ Southport Merseyside | United Kingdom | British | 29177910001 | |||||
| BENTZ, Brian | Director | 4069 West 36th Avenue V6N 2T1 Vancouver British Columbia | Canadian | 50780300001 | ||||||
| BROWN, Anthony Robert | Director | 68a Cornwall Road HG1 2NE Harrogate North Yorkshire | British | 67946780002 | ||||||
| CHALLENGER, Paul | Director | 37 Dalehead Road Leyland PR25 3AY Preston Lancashire | United Kingdom | British | 73317130001 | |||||
| CHAMBERLAIN, Janet Patricia | Director | 15 Oakley Close CW11 1RQ Sandbach Cheshire | United Kingdom | British | 51278380001 | |||||
| CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd | Director | 58 Bracken Road HX6 2HR Brighouse West Yorkshire | British | 107105790003 | ||||||
| CLAMPETT, Richard Martin | Director | Stonerest Stone Lane, Emley HD8 9RT Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | 91834040001 | |||||
| CLAYTON, Brian | Director | Mayfield Tattenhall Road Tattenhall CH3 9NA Chester Cheshire | British | 11435130001 | ||||||
| COWPER, Jonathan | Director | 2 Bluebell Close Etherley Dene DL14 0TL Bishop Auckland County Durham | British | 124817460001 | ||||||
| DODD, Phillip Joseph | Director | 15 The Greenway Ickenham UB10 8LS Uxbridge Middlesex | United Kingdom | British | 77844000001 | |||||
| EARLY, John Dalton | Director | 3 Mayfair Park Off Mersey Road Didsbury M20 2JW Manchester | England | British | 4150930007 | |||||
| HODKINSON, David John | Director | 31 Stainthorpe Court Battle Hill NE46 1WY Hexham Northumberland | United Kingdom | British | 124817390001 | |||||
| HOYLE, David | Director | Whitebirk House 478 Holcombe Road BL8 4HB Bury Lancashire | United Kingdom | British | 78965860008 | |||||
| LING, Grant Richmond | Director | Flat 24 The Academy 16 Highgate Hill N19 5NS London | England | British | 68935320003 | |||||
| MARLOW, Michael John | Director | High Walls Chapel Lane LE7 4WB Gadsby Leicester | British | 37855050001 | ||||||
| MCLEAN, Andrew Stuart | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British | 262737780002 | |||||
| O'BRIEN, Daniel Terence | Director | 47 Willowmead Drive Prestbury SK10 4DD Macclesfield Cheshire | British | 52052530001 | ||||||
| PLANT, Matthew Nigel | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | United Kingdom | British | 61489190001 | |||||
| POPE, Barry Robert Boyde | Director | 44 Farleigh Road New Haw, New Haw KT15 3HR Addlestone | England | British | 124951060001 | |||||
| ROGERS, Peter Anthony | Director | 18 Manchester Road WA16 0NT Knutsford Cheshire | British/Canadian | 71656590001 | ||||||
| SETTER, William George | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | Scotland | British | 147116630004 | |||||
| TODD, Stephen Charles | Director | The Old Forge The Square Nether Wallop SO20 8EX Stockbridge Hampshire | England | British | 108216800001 | |||||
| WOLSTENHOLME, Ian John | Director | 12 Crag Avenue Summerseat BL9 5NZ Bury Lancashire | England | British | 84788710003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AMEC PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amec Foster Wheeler Plc | 06 abr 2016 | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Amec Foster Wheeler Group Limited | 06 abr 2016 | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0