BASILICA COMPUTING LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | BASILICA COMPUTING LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02624451 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BASILICA COMPUTING LIMITED?
- Actividades de consultoría en tecnología de la información (62020) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra BASILICA COMPUTING LIMITED?
Dirección de la sede social | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BASILICA COMPUTING LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
RENTSTRONG LIMITED | 27 jun 1991 | 27 jun 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BASILICA COMPUTING LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BASILICA COMPUTING LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 9 páginas | 4.71 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 dic 2016 | 16 páginas | 4.68 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 dic 2016 | 8 páginas | 4.68 | ||||||||||
Orden judicial de insolvencia Court order insolvency:c/o replacement of liquidator | 11 páginas | LIQ MISC OC | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario | 1 páginas | 4.40 | ||||||||||
Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario | 1 páginas | 4.40 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Presentación de insolvencia INSOLVENCY:order of court in repsect of replacement liquidators | 13 páginas | LIQ MISC | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Orden judicial de insolvencia Court order INSOLVENCY:replacement of liquidator | 17 páginas | LIQ MISC OC | ||||||||||
Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario | 1 páginas | 4.40 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 81 Newgate Street London EC1A 7AJ | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Bt Plc 81 Newgate Street London EC1A 7AJ a 81 Newgate Street London EC1A 7AJ | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 dic 2015 | 7 páginas | 4.68 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 dic 2014 | 7 páginas | 4.68 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Mark Jonathan Hendricks el 14 feb 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 81 Newgate Street London EC1A 7AJ United Kingdom | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * 1 Letchworth Business Centre Avenue One Letchworth Hertfordshire SG6 2HB* el 31 dic 2013 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 jun 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012 | 15 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BASILICA COMPUTING LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWGATE STREET SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 81 Newgate Street EC1A 7AJ London | 45816950001 | |||||||
HENDRICKS, Mark Jonathan | Director | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d United Kingdom | England | British | Accountant | 137885640003 | ||||
LOWE, Richard James | Director | 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d Bt Centre United Kingdom | United Kingdom | Australian | Chartered Accountant | 83353420004 | ||||
MADDAFORD, Elizabeth Jane | Secretario | Old Farm Station Road Stanbridge LU7 9JF Leighton Buzzard Bedfordshire | British | Systems Consultant | 15793960002 | |||||
MULLINER, Allan Peter | Secretario | 2 Pyket Way Weston Favell NN3 3JU Northampton Northamptonshire | British | 47900350001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BRAND, Stephen Albert John | Director | 9 Spencer Close Brookmans CM12 0GF Billericay Essex | British | Director | 107544000001 | |||||
BROWN, Alan | Director | Barnside House Kimbolton Road Lower Dean PE18 0LJ Huntingdon Cambridgeshire | British | Sales | 61985130001 | |||||
CHATT, Martin | Director | Ridges Hightown Green Rattlesden IP30 0SZ Bury St Edmunds Suffolk | British | Accountant | 124505220001 | |||||
COLE, Michael John | Director | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d United Kingdom | United Kingdom | British | Governance Manager | 137411950001 | ||||
DOUGLAS, Andrew Grant | Director | Elmhora Upnor ME2 4XE Rochester Kent | England | British | Director | 51576130002 | ||||
DRAPER, Robin Alexander | Director | 51 Dallington Road NN5 7BW Northampton Northamptonshire | England | British | Finance Director | 106680120001 | ||||
DUXBURY, Stephen | Director | 4 Poppylands OX26 3ZP Bicester Oxfordshire | British | It Services | 89163930001 | |||||
GEORGE, James | Director | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d United Kingdom | British | Accountant | 99160240001 | |||||
GORRINGE, Nicholas | Director | 1 Letchworth Business Centre Avenue One SG6 2HB Letchworth Hertfordshire | British | Director | 58177460002 | |||||
HOULT, Andrew James | Director | The Old Mill Hollygate Road, Ridlington LE15 9AR Rutland | United Kingdom | British | Computer Salesman | 99631970001 | ||||
KENNY, Julian | Director | 35 The Haydens TN9 1NS Tonbridge Kent | England | British | Finance Director | 83155900003 | ||||
LEIGH, Christopher Martin | Director | 18 The Uplands AL5 2PQ Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Operations Manager | 38527060005 | ||||
MADDAFORD, Elizabeth Jane | Director | Old Farm Station Road Stanbridge LU7 9JF Leighton Buzzard Bedfordshire | British | Company Director | 15793960002 | |||||
MATTEY, Colin | Director | 6 Fairways Penton CH42 8JZ Birkenhead Merseyside | England | British | Director Of Sales | 124654000001 | ||||
MATTEY, Colin | Director | 6 Fairways Penton CH42 8JZ Birkenhead Merseyside | England | British | Director Of Sales | 124654000001 | ||||
MCAULAY, Alan | Director | Sorauren Old Gartmore Road Drymen G63 0DP Glasgow | Scotland | British | Executive | 36746100001 | ||||
MULLINER, Allan Peter | Director | 1 Letchworth Business Centre Avenue One SG6 2HB Letchworth Hertfordshire | United Kingdom | British | Commercial Director | 47900350001 | ||||
OKEEFE, Patrick Mark | Director | 13 Daisy Bank Drive CW11 4JR Sandbach Cheshire | British | Director | 65756320001 | |||||
ROBERTS, Paul Timothy | Director | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d United Kingdom | England | United Kingdom | Accountant | 124821730001 | ||||
RYAN, Christina Bridget | Director | Bt Centre 81 Newgate Street EC1A 7AJ London Pp A9d United Kingdom | United Kingdom | Irish | Company Secretary | 35354830001 | ||||
SPARROW, Richard John | Director | 38 Hampden Road SG4 0LD Hitchin Hertfordshire | British | Sales | 74151310002 | |||||
VASSILIADES, Steven | Director | Middleton Hall EH23 4RD Gorebridge Midlothian | British | Director | 47900510002 | |||||
WADSWORTH, David Jeffrey | Director | 47 Merthyr Terrace Barnes SW13 8DL London | England | British | Chartered Accountant | 36338230001 | ||||
WILTSHIRE, Nicholas | Director | Sun Cottage 6 Sun Street Potton SG19 2LR Sandy Bedfordshire | British | Enterprise Sales Director | 92932320001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Tiene BASILICA COMPUTING LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creado el 23 mar 2001 Entregado el 04 abr 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed | |
Breve descripción £8,827.50. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
All assets debenture deed | Creado el 01 may 1997 Entregado el 09 may 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 24 jun 1993 Entregado el 01 jul 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Lease | Creado el 01 feb 1993 Entregado el 05 feb 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease | |
Breve descripción Rent deposit of £1000. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Lease | Creado el 12 nov 1992 Entregado el 25 nov 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease | |
Breve descripción Rental deposit of £2,000 referred to in clause 5 of lease. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene BASILICA COMPUTING LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0