PERUDA LEASING LIMITED

PERUDA LEASING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPERUDA LEASING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02638677
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PERUDA LEASING LIMITED?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra PERUDA LEASING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Interpath Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PERUDA LEASING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ABBEY NATIONAL JUNE LEASING (3) LIMITED01 may 199201 may 1992
    FOCUSLOCAL LIMITED16 ago 199116 ago 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PERUDA LEASING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PERUDA LEASING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    18 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB a C/O Interpath Limited 10 Fleet Place London EC4M 7RB el 28 jul 2023

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    4 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 28 jun 2023

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    7 páginasLIQ01

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    4 páginasMR04

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2021

    12 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2020

    12 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    13 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Christopher Charles Snailham el 31 oct 2017

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    12 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Matthew James Thorne como director el 18 dic 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Kenyon Thomas como director el 30 nov 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2018 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 12 oct 2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    ¿Quiénes son los directivos de PERUDA LEASING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BAGSHAW, Joanne Louise
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Secretario
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    180380540001
    BARTLETT, Andrew William
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Secretario
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British73852930003
    SNAILHAM, Christopher Charles
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    United KingdomBritish202149290001
    THORNE, Matthew
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    United KingdomBritish267811560001
    BURTON, Jennifer Sandra
    39b Butler Avenue
    HA1 4EJ West Harrow
    Middlesex
    Secretario
    39b Butler Avenue
    HA1 4EJ West Harrow
    Middlesex
    British100622570001
    FLETCHER, Edward Michael
    3 Aldrich Terrace
    SW18 3PU Earlsfield
    Secretario
    3 Aldrich Terrace
    SW18 3PU Earlsfield
    British78572640002
    NAGRECHA, Lenna
    2 Oaktree Close
    HA7 2PX Stanmore
    Middlesex
    Secretario
    2 Oaktree Close
    HA7 2PX Stanmore
    Middlesex
    British4949790001
    RUTHERFORD, Adam Paul
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Secretario
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British70451850004
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    Secretario corporativo
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    61749570003
    BATCHELOR, Gwendoline Mary
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    Director
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    British34184100001
    BATCHELOR, Gwendoline Mary
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    Director
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    British34184100001
    COHEN, Jonathan Paul
    13 Gowan Lea
    15 Woodford Road
    E18 2ER London
    Director
    13 Gowan Lea
    15 Woodford Road
    E18 2ER London
    EnglandBritish26953400001
    EDWARDS, Shirley Ann Elizabeth
    Tilbrook Mill
    Lower Dean
    PE28 0LH Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    Tilbrook Mill
    Lower Dean
    PE28 0LH Huntingdon
    Cambridgeshire
    British61855020002
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Director
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    GARRATT, Robin
    Wansunt Road
    DA5 2DN Bexley
    107
    Kent
    Director
    Wansunt Road
    DA5 2DN Bexley
    107
    Kent
    EnglandBritish14290340001
    GOLDSBROUGH, Christopher Andrew John
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    United KingdomBritish/New Zealand153832500002
    GREEN, David Martin
    7 Restharrow Road
    Weavering
    ME14 5UH Maidstone
    Kent
    Director
    7 Restharrow Road
    Weavering
    ME14 5UH Maidstone
    Kent
    British83033800001
    HARLEY, Ian
    36 Kersey Drive
    Selsdon Ridge
    CR2 8SX South Croydon
    Surrey
    Director
    36 Kersey Drive
    Selsdon Ridge
    CR2 8SX South Croydon
    Surrey
    British25941180001
    HOYLE, Stephen Lewis
    2 Haslemere Road
    N8 9QX London
    Director
    2 Haslemere Road
    N8 9QX London
    United KingdomBritish96838010001
    HUTCHISON, Sarah Anne
    77 Parliament Hill
    NW3 2TH London
    Director
    77 Parliament Hill
    NW3 2TH London
    British36372610001
    JONES, David Gareth
    Hillhouse Farm
    Misbrooks Green Road Beare Green
    RH5 4QQ Dorking
    Surrey
    Director
    Hillhouse Farm
    Misbrooks Green Road Beare Green
    RH5 4QQ Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish6205890002
    JONES, David Gareth
    The Buffers
    11 Deepdene Drive
    RH5 4AH Dorking
    Surrey
    Director
    The Buffers
    11 Deepdene Drive
    RH5 4AH Dorking
    Surrey
    British6205890001
    JULIAN, Suzanne Margaret
    25 Quick Road
    Chiswick
    W4 2BU London
    Director
    25 Quick Road
    Chiswick
    W4 2BU London
    British36432460001
    LONG, Graham Stephen
    22 Cumberland Road
    SW13 9LY London
    Director
    22 Cumberland Road
    SW13 9LY London
    British38022070005
    LOWE, William Nairn
    Briar Gap
    Loseberry Road
    KT10 9DQ Claygate
    Surrey
    Director
    Briar Gap
    Loseberry Road
    KT10 9DQ Claygate
    Surrey
    EnglandBritish282371920001
    MACFARLANE, Stuart Edward
    29 Leaside Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BT London
    Director
    29 Leaside Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BT London
    Australian125721120001
    MACFARLANE, Stuart Edward
    6 Lynmouth Road
    East Finchley
    N2 9LS London
    Director
    6 Lynmouth Road
    East Finchley
    N2 9LS London
    Australian125721120002
    MCGIDDY, Mark Andrew
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    Director
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    Australian114990900003
    MERRICK, Anna
    27 Jacksons Lane
    Highgate
    N6 5SR London
    Director
    27 Jacksons Lane
    Highgate
    N6 5SR London
    British39621110002
    NICHOLLS, Jonathan Clive
    Longmeadow
    Prinsted Lane
    PO10 8HR Emsworth
    Hampshire
    Director
    Longmeadow
    Prinsted Lane
    PO10 8HR Emsworth
    Hampshire
    United KingdomEnglish127532290001
    OSWALD JACOBS, John James
    15 Clapham Common West Side
    SW4 9AJ London
    Director
    15 Clapham Common West Side
    SW4 9AJ London
    Australian77965500001
    PRESS, Matthew
    106 Ledbury Road
    W11 2AH London
    Director
    106 Ledbury Road
    W11 2AH London
    Australian104610910001
    SHAH, Rumit
    32 The Drive
    HA6 1HP Northwood
    Middlesex
    Director
    32 The Drive
    HA6 1HP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish101964890001
    SIVANITHY, Rajanbabu
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United KingdomBritish63268810003
    THOMAS, David Kenyon
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    England
    England
    Director
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    England
    England
    United KingdomBritish59397060006

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PERUDA LEASING LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04560735
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene PERUDA LEASING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A deed of covenant
    Creado el 19 ene 2006
    Entregado el 07 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The vessel "ramform victory" registered on the bahamas flag with serial number 8000855 and includes any share or interest therin and her engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Pgs Shipping (Isle of Man) Limited
    Transacciones
    • 07 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    A first priority bahamas ship mortgage
    Creado el 19 ene 2006
    Entregado el 07 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    64 shares in the vessel "ramform victory" registered on the bahamas flag at the port of nassau with official number 8000855 and includes her boats guns ammunition small arms appurtenances.
    Personas con derecho
    • Pgs Shipping (Isle of Man) Limited
    Transacciones
    • 07 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Security assignment
    Creado el 18 dic 2003
    Entregado el 23 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Up to a maximum principal amount of £182,000,000 due or to become due from the company to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    With full title guarantee, the assigned property being the lease; the guarantee; any and all other guarantees; all claims, rights and remedies of the assignor arising out of or in connection with a breach of or default under or in connection with any of the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag London
    Transacciones
    • 23 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2022Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene PERUDA LEASING LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    28 jun 2023Inicio de la liquidación
    30 jun 2024Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Howard Smith
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profesional
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicholas James Timpson
    Interpath Limited 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profesional
    Interpath Limited 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0