PERUDA LEASING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PERUDA LEASING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02638677 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PERUDA LEASING LIMITED?
- Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra PERUDA LEASING LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Interpath Limited 10 Fleet Place EC4M 7RB London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PERUDA LEASING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ABBEY NATIONAL JUNE LEASING (3) LIMITED | 01 may 1992 | 01 may 1992 |
| FOCUSLOCAL LIMITED | 16 ago 1991 | 16 ago 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PERUDA LEASING LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PERUDA LEASING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 18 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB a C/O Interpath Limited 10 Fleet Place London EC4M 7RB el 28 jul 2023 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 4 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2021 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2020 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Christopher Charles Snailham el 31 oct 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Matthew James Thorne como director el 18 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Kenyon Thomas como director el 30 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 12 oct 2017
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PERUDA LEASING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGSHAW, Joanne Louise | Secretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | 180380540001 | |||||||
| BARTLETT, Andrew William | Secretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 73852930003 | ||||||
| SNAILHAM, Christopher Charles | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British | 202149290001 | |||||
| THORNE, Matthew | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British | 267811560001 | |||||
| BURTON, Jennifer Sandra | Secretario | 39b Butler Avenue HA1 4EJ West Harrow Middlesex | British | 100622570001 | ||||||
| FLETCHER, Edward Michael | Secretario | 3 Aldrich Terrace SW18 3PU Earlsfield | British | 78572640002 | ||||||
| NAGRECHA, Lenna | Secretario | 2 Oaktree Close HA7 2PX Stanmore Middlesex | British | 4949790001 | ||||||
| RUTHERFORD, Adam Paul | Secretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 70451850004 | ||||||
| ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Abbey National House 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London | 61749570003 | |||||||
| BATCHELOR, Gwendoline Mary | Director | 26 Crescent Wood Road SE26 6RU London | British | 34184100001 | ||||||
| BATCHELOR, Gwendoline Mary | Director | 26 Crescent Wood Road SE26 6RU London | British | 34184100001 | ||||||
| COHEN, Jonathan Paul | Director | 13 Gowan Lea 15 Woodford Road E18 2ER London | England | British | 26953400001 | |||||
| EDWARDS, Shirley Ann Elizabeth | Director | Tilbrook Mill Lower Dean PE28 0LH Huntingdon Cambridgeshire | British | 61855020002 | ||||||
| ELLIS, David James | Director | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | 113760650001 | |||||
| GARRATT, Robin | Director | Wansunt Road DA5 2DN Bexley 107 Kent | England | British | 14290340001 | |||||
| GOLDSBROUGH, Christopher Andrew John | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British/New Zealand | 153832500002 | |||||
| GREEN, David Martin | Director | 7 Restharrow Road Weavering ME14 5UH Maidstone Kent | British | 83033800001 | ||||||
| HARLEY, Ian | Director | 36 Kersey Drive Selsdon Ridge CR2 8SX South Croydon Surrey | British | 25941180001 | ||||||
| HOYLE, Stephen Lewis | Director | 2 Haslemere Road N8 9QX London | United Kingdom | British | 96838010001 | |||||
| HUTCHISON, Sarah Anne | Director | 77 Parliament Hill NW3 2TH London | British | 36372610001 | ||||||
| JONES, David Gareth | Director | Hillhouse Farm Misbrooks Green Road Beare Green RH5 4QQ Dorking Surrey | United Kingdom | British | 6205890002 | |||||
| JONES, David Gareth | Director | The Buffers 11 Deepdene Drive RH5 4AH Dorking Surrey | British | 6205890001 | ||||||
| JULIAN, Suzanne Margaret | Director | 25 Quick Road Chiswick W4 2BU London | British | 36432460001 | ||||||
| LONG, Graham Stephen | Director | 22 Cumberland Road SW13 9LY London | British | 38022070005 | ||||||
| LOWE, William Nairn | Director | Briar Gap Loseberry Road KT10 9DQ Claygate Surrey | England | British | 282371920001 | |||||
| MACFARLANE, Stuart Edward | Director | 29 Leaside Avenue Muswell Hill N10 3BT London | Australian | 125721120001 | ||||||
| MACFARLANE, Stuart Edward | Director | 6 Lynmouth Road East Finchley N2 9LS London | Australian | 125721120002 | ||||||
| MCGIDDY, Mark Andrew | Director | Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House 1 | Australian | 114990900003 | ||||||
| MERRICK, Anna | Director | 27 Jacksons Lane Highgate N6 5SR London | British | 39621110002 | ||||||
| NICHOLLS, Jonathan Clive | Director | Longmeadow Prinsted Lane PO10 8HR Emsworth Hampshire | United Kingdom | English | 127532290001 | |||||
| OSWALD JACOBS, John James | Director | 15 Clapham Common West Side SW4 9AJ London | Australian | 77965500001 | ||||||
| PRESS, Matthew | Director | 106 Ledbury Road W11 2AH London | Australian | 104610910001 | ||||||
| SHAH, Rumit | Director | 32 The Drive HA6 1HP Northwood Middlesex | England | British | 101964890001 | |||||
| SIVANITHY, Rajanbabu | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | United Kingdom | British | 63268810003 | |||||
| THOMAS, David Kenyon | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House England England | United Kingdom | British | 59397060006 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PERUDA LEASING LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempurrite Leasing Limited | 06 abr 2016 | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene PERUDA LEASING LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of covenant | Creado el 19 ene 2006 Entregado el 07 feb 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The vessel "ramform victory" registered on the bahamas flag with serial number 8000855 and includes any share or interest therin and her engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A first priority bahamas ship mortgage | Creado el 19 ene 2006 Entregado el 07 feb 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción 64 shares in the vessel "ramform victory" registered on the bahamas flag at the port of nassau with official number 8000855 and includes her boats guns ammunition small arms appurtenances. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security assignment | Creado el 18 dic 2003 Entregado el 23 dic 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Up to a maximum principal amount of £182,000,000 due or to become due from the company to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción With full title guarantee, the assigned property being the lease; the guarantee; any and all other guarantees; all claims, rights and remedies of the assignor arising out of or in connection with a breach of or default under or in connection with any of the agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene PERUDA LEASING LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0