DELTA RADIO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDELTA RADIO LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02642617
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DELTA RADIO LIMITED?

    • Radiodifusión (60100) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra DELTA RADIO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DELTA RADIO LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WEY VALLEY RADIO LTD04 sept 199204 sept 1992
    THIRD MILE INVESTMENT LTD.04 oct 199104 oct 1991
    ALLIED RADIO LIMITED03 sept 199103 sept 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DELTA RADIO LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DELTA RADIO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Declaración de confirmación presentada el 23 may 2021 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 sept 2020 au 31 dic 2020

    1 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2019

    7 páginasAA

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share premium account cancelled 15/09/2020
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital el 01 oct 2020

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    Declaración de confirmación presentada el 23 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 23 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Diedre Ann Ford el 31 ene 2019

    2 páginasCH01

    Modification des détails de Celador Radio Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 feb 2019

    2 páginasPSC05

    Cessation de Celador Entertainment Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ene 2019

    1 páginasPSC07

    Notification de Celador Radio Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ene 2019

    2 páginasPSC02

    Cese del nombramiento de Paul Adrian Smith como director el 31 ene 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Michael Charman como director el 31 ene 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Bauer Group Secretariat Limited como secretario el 31 ene 2019

    2 páginasAP04

    Nombramiento de Mrs Sarah Jane Vickery como director el 31 ene 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Anthony Keenan como director el 31 ene 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Diedre Ann Ford como director el 31 ene 2019

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Celador Radio Roman Landing Kingsway Southampton Hampshire SO14 1BN England a Media House Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6EA el 15 feb 2019

    1 páginasAD01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 sept 2018

    2 páginasAA

    Cessation de Celador Entertainment Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 jul 2018

    1 páginasPSC07

    ¿Quiénes son los directivos de DELTA RADIO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish255749500002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish39692770004
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    United KingdomBritish119137220002
    BRUCE, David Kevin
    10 Huxley Close
    GU7 2AS Godalming
    Surrey
    Secretario
    10 Huxley Close
    GU7 2AS Godalming
    Surrey
    British37948150001
    CHRISTMAS, Colin Roy George
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    Secretario
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    British1678140002
    CLAYTON, Yvonne Lynn
    South Bank
    31a Woodland Avenue
    TR10 8PG Penryn
    Cornwall
    Secretario
    South Bank
    31a Woodland Avenue
    TR10 8PG Penryn
    Cornwall
    British40640850001
    JOHNSON, Mark Alasdair Smith
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    Secretario
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    171897870001
    KITNEY, Stephen James
    Sunchyme15 Tongham Road
    Runfold
    GU10 1PH Farnham
    Surrey
    Secretario
    Sunchyme15 Tongham Road
    Runfold
    GU10 1PH Farnham
    Surrey
    British90188890001
    RUSHTON, June Elizabeth
    100 London Road
    Holybourne
    GU34 4EW Alton
    Hampshire
    Secretario
    100 London Road
    Holybourne
    GU34 4EW Alton
    Hampshire
    British31945390001
    YATES, Susan Ruth
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    The Old Court House
    Surrey
    Secretario
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    The Old Court House
    Surrey
    British55952690003
    BAKER, John
    1 Pound Cottages
    Stroud Green
    RG14 7JH Newbury
    Berkshire
    Director
    1 Pound Cottages
    Stroud Green
    RG14 7JH Newbury
    Berkshire
    British122288220001
    BRUCE, David Kevin
    10 Huxley Close
    GU7 2AS Godalming
    Surrey
    Director
    10 Huxley Close
    GU7 2AS Godalming
    Surrey
    British37948150001
    CHARMAN, Paul Michael
    Kingsway
    St. Marys Place
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    Director
    Kingsway
    St. Marys Place
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    EnglandBritish226735460001
    CHEESEWRIGHT, Gillian Anne Elizabeth
    23 Beechlands Road
    Medstead
    GU34 5EQ Alton
    Hampshire
    Director
    23 Beechlands Road
    Medstead
    GU34 5EQ Alton
    Hampshire
    British34511210001
    CHRISTMAS, Colin Roy George
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    Director
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    EnglandBritish1678140002
    CRAIG, Wendy Diane, Mrs.
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    The Old Court House
    Surrey
    Director
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    The Old Court House
    Surrey
    United KingdomBritish57867210001
    DOEL, Brian Gilroy
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    The Old Court House
    Surrey
    Director
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    The Old Court House
    Surrey
    EnglandBritish107694860001
    HANDLEY, Valerie Jayne
    Spring Cottage
    Stoney Bottom Grayshott
    GU26 6HN Hindhead
    Surrey
    Director
    Spring Cottage
    Stoney Bottom Grayshott
    GU26 6HN Hindhead
    Surrey
    EnglandBritish44328220001
    HARRIS, Martyn Vaughan
    5 The Cloisters
    Steeple Drive
    GU34 1TW Alton
    Hampshire
    Director
    5 The Cloisters
    Steeple Drive
    GU34 1TW Alton
    Hampshire
    British15804830001
    HAWKSLEY, Andrew
    c/o Celador Radio
    Kingsway
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    Director
    c/o Celador Radio
    Kingsway
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    EnglandBritish244980330001
    HEDGES, Gerald Michael
    64 Patricks Copse Road
    GU33 7DW Liss
    Hampshire
    Director
    64 Patricks Copse Road
    GU33 7DW Liss
    Hampshire
    British3309540001
    ISAAC, Keith Shelby
    Clare Cottage Fir Tree Road
    KT22 8RF Leatherhead
    Surrey
    Director
    Clare Cottage Fir Tree Road
    KT22 8RF Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish5862580001
    JOHNSON, Mark Alasdair Smith
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    Director
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    EnglandBritish79195840006
    KITNEY, Stephen James
    Sunchyme15 Tongham Road
    Runfold
    GU10 1PH Farnham
    Surrey
    Director
    Sunchyme15 Tongham Road
    Runfold
    GU10 1PH Farnham
    Surrey
    British90188890001
    LAWLEY, Richard Henry John
    3 Pine Bank
    GU26 6SR Hindhead
    Surrey
    Director
    3 Pine Bank
    GU26 6SR Hindhead
    Surrey
    EnglandBritish83623820001
    MANN, Paul
    80 Normandy Street
    GU34 1DH Alton
    Hampshire
    Director
    80 Normandy Street
    GU34 1DH Alton
    Hampshire
    English31945400001
    MANN, Terrence Keith
    23 Hillside Crescent
    Uplands
    SA2 0RD Swansea
    Director
    23 Hillside Crescent
    Uplands
    SA2 0RD Swansea
    WalesBritish37372220003
    MARCUS, Paul Arthur
    206 Mytchett Road
    GU16 6AE Camberley
    Surrey
    Director
    206 Mytchett Road
    GU16 6AE Camberley
    Surrey
    EnglandBritish114397970001
    ODELL, Melanie Jill
    18 Chestnut Avenue
    GU27 2AT Haslemere
    Surrey
    Director
    18 Chestnut Avenue
    GU27 2AT Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish67969220001
    PAYNE, Susan Elizabeth
    89 New Cross Road
    GU2 9NU Guildford
    Surrey
    Director
    89 New Cross Road
    GU2 9NU Guildford
    Surrey
    British78913920001
    POWELL, Michael Leslie
    Nightingale Cottage
    Great Holt Old Lane Dockenfield
    GU10 4HQ Farnham
    Surrey
    Director
    Nightingale Cottage
    Great Holt Old Lane Dockenfield
    GU10 4HQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish11273310001
    PRIOR, Rosemary
    17 Woodpecker Close
    GU35 0UR Bordon
    Hampshire
    Director
    17 Woodpecker Close
    GU35 0UR Bordon
    Hampshire
    British89707450001
    ROGERS, William James Gerald
    16 Regent Square
    TR18 4BG Penzance
    Cornwall
    Director
    16 Regent Square
    TR18 4BG Penzance
    Cornwall
    British37957110002
    RUSHTON, June Elizabeth
    Draycott House
    3a Blackberry Lane, Four Marks
    GU34 5BN Alton
    Hampshire
    Director
    Draycott House
    3a Blackberry Lane, Four Marks
    GU34 5BN Alton
    Hampshire
    British31945390002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de DELTA RADIO LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    31 ene 2019
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05439096
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Paddington House
    Festival Place
    RG21 7JN Basingstoke
    Suite 2
    England
    06 abr 2016
    Paddington House
    Festival Place
    RG21 7JN Basingstoke
    Suite 2
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05679435
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Kingsway
    St. Marys Place
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    06 abr 2016
    Kingsway
    St. Marys Place
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05679435
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene DELTA RADIO LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 27 mar 2001
    Entregado el 29 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Breve descripción
    All monies standing to the creedit of a deposit account opened by the landlord pursuant to the lease.
    Personas con derecho
    • David Henry James Kemp, Judith Kemp, Christopher Mark Kemp and Sarah Jane Rose
    Transacciones
    • 29 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 10 feb 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 22 ene 2000
    Entregado el 11 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 27 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 16 oct 1992
    Entregado el 20 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Breve descripción
    The sum of £3,650 under the lease.
    Personas con derecho
    • D.H.J. Kemp
    • C.M. Kemp
    • S.J. Rose
    • J. Kemp
    Transacciones
    • 20 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 10 feb 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0