BALTIMORE CAPITAL PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBALTIMORE CAPITAL PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 02643615
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BALTIMORE CAPITAL PLC?

    • (7020) /

    ¿Dónde se encuentra BALTIMORE CAPITAL PLC?

    Dirección de la sede social
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BALTIMORE CAPITAL PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BALTIMORE PLC15 abr 200515 abr 2005
    BALTIMORE TECHNOLOGIES PLC14 may 199914 may 1999
    ZERGO HOLDINGS PLC10 sept 199310 sept 1993
    ZERGO LIMITED27 jul 199227 jul 1992
    ZEDSERVE LIMITED06 sept 199106 sept 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BALTIMORE CAPITAL PLC?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BALTIMORE CAPITAL PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 mar 2016

    10 páginas4.68

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:secretary of state release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 mar 2015

    10 páginas4.68

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq
    47 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 mar 2014

    11 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 mar 2013

    10 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 mar 2012

    10 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de * C/O J O Hambro Capital Management Limited Ground Floor Ryder Court 14 Ryder Street London SW1Y 6QB* el 06 abr 2011

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Nigel Cayzer como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Radziwill como director

    1 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2009

    18 páginasAA

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Déclaration annuelle établie au 06 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 sept 2010

    Estado de capital el 27 sept 2010

    • Capital: GBP 1,952,539.85
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de BALTIMORE CAPITAL PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ryder Court
    England
    Secretario corporativo
    Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ryder Court
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro02176004
    36581310005
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    Director
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    United KingdomBritishInvestment Manager35557050001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Secretario
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    GUNTRIP, Bonita
    Ground Floor Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Secretario
    Ground Floor Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    BritishCompany Secretary115073990001
    HENLEY PRICE, Julian Kendall
    29a Stockwell Park Road
    SW9 0AP London
    Secretario
    29a Stockwell Park Road
    SW9 0AP London
    BritishLegal Counsel100872540001
    KELLY, Denis Paul
    592 South Circular Road
    Kilmainham
    Dublin 8
    Ireland
    Secretario
    592 South Circular Road
    Kilmainham
    Dublin 8
    Ireland
    IrishChief Financial Officer Chief95845190001
    LOOSLEY, Roger John
    5 Hampton Lane
    SO22 5LF Winchester
    Hampshire
    Secretario
    5 Hampton Lane
    SO22 5LF Winchester
    Hampshire
    British50660050001
    LOVELL, Timothy James Carey
    42 Stradella Road
    SE24 9HA London
    Secretario
    42 Stradella Road
    SE24 9HA London
    BritishDirector7777210001
    SMITH, Kenneth Philip
    11 Bracebridge Road
    Four Oaks
    B74 2SB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretario
    11 Bracebridge Road
    Four Oaks
    B74 2SB Sutton Coldfield
    West Midlands
    British42650490001
    VILAR, Alfredo Goyanes
    Vilualia S1 Julian Hernandez,
    12 Bloque B 2nd Piso
    FOREIGN Madrid
    28043
    Spain
    Secretario
    Vilualia S1 Julian Hernandez,
    12 Bloque B 2nd Piso
    FOREIGN Madrid
    28043
    Spain
    SpanishCompany Director100326710001
    WATSON, John Stewart Lacon
    Avon Lodge
    Station Approach
    TW17 8AL Shepperton
    Middlesex
    Secretario
    Avon Lodge
    Station Approach
    TW17 8AL Shepperton
    Middlesex
    British38874570002
    WALGATE SERVICES LIMITED
    Walgate House
    25 Church Street
    RG21 7QQ Basingstoke
    Hampshire
    Secretario corporativo
    Walgate House
    25 Church Street
    RG21 7QQ Basingstoke
    Hampshire
    807800002
    BEKER, Henry Joseph
    34 Luckley Wood
    RG11 3EW Wokingham
    Berkshire
    Director
    34 Luckley Wood
    RG11 3EW Wokingham
    Berkshire
    BritishEngineer69186450001
    BOWCOCK, Matthew Philip
    708 Portwalk Place
    Redwood City Ca 94065
    FOREIGN Usa
    Director
    708 Portwalk Place
    Redwood City Ca 94065
    FOREIGN Usa
    BritishMarketing Director72343790001
    BUCHLER, David Julian
    52 Bryanston Court
    George Street
    W1H 7HB London
    Director
    52 Bryanston Court
    George Street
    W1H 7HB London
    United KingdomBritishAccountant77441110005
    BUNKER, Christopher Jonathan
    9 Regents Riverside
    Brigham Road
    RG1 8QS Reading
    Berkshire
    Director
    9 Regents Riverside
    Brigham Road
    RG1 8QS Reading
    Berkshire
    BritishAccountant77062320001
    CAYZER, Nigel Kenneth, Mr.
    Thriepley House
    Lundie
    DD2 5PA Dundee
    Director
    Thriepley House
    Lundie
    DD2 5PA Dundee
    United KingdomBritishCompany Director16957900001
    COLE, Gerald Maurice
    6 Curl Way
    RG41 2TJ Wokingham
    Berkshire
    Director
    6 Curl Way
    RG41 2TJ Wokingham
    Berkshire
    BritishEngineer20901700001
    CUNNINGHAM, John Patrick
    6 Stockbridge Road
    Mountkisco
    New York Ny 10549
    Usa
    Director
    6 Stockbridge Road
    Mountkisco
    New York Ny 10549
    Usa
    AmericanDirector72487480002
    ENGLANDER, Peter
    24 Upper Brook Street
    W1 London
    Director
    24 Upper Brook Street
    W1 London
    BritishVenture Capitalist20915210002
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Director
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritishCompany Secretary61314280001
    EYRE, Richard Anthony
    The Copper Beech
    Walking Bottom
    GU5 9RR Peaslake
    Surrey
    Director
    The Copper Beech
    Walking Bottom
    GU5 9RR Peaslake
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director5219910002
    GUYATT, David Ashley
    The Old School
    Basingstoke Road
    RG26 5RB Ramsdell
    Hampshire
    Director
    The Old School
    Basingstoke Road
    RG26 5RB Ramsdell
    Hampshire
    BritishCompany Director28585070004
    HUNT, Andrew Nicholas
    22 Ibsley Way
    EN4 9EY Cockfosters
    Hertfordshire
    Director
    22 Ibsley Way
    EN4 9EY Cockfosters
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector99349350001
    HUSTON, James Edward
    Je Huston & Associates
    PO BOX 1186
    Sudbury
    Ma 01776
    Usa
    Director
    Je Huston & Associates
    PO BOX 1186
    Sudbury
    Ma 01776
    Usa
    AmericanConsultant98603820001
    KELLY, Denis Paul
    592 South Circular Road
    Kilmainham
    Dublin 8
    Ireland
    Director
    592 South Circular Road
    Kilmainham
    Dublin 8
    Ireland
    IrishChief Financial Officer Chief95845190001
    KHEZRI, Bijan Daniel
    40 Winchester Street
    SW1V 4NF London
    Director
    40 Winchester Street
    SW1V 4NF London
    GermanFinance73413860001
    KHEZRI, Bijan Daniel
    40 Winchester Street
    SW1V 4NF London
    Director
    40 Winchester Street
    SW1V 4NF London
    GermanFinance73413860001
    LOVELL, Timothy James Carey
    42 Stradella Road
    SE24 9HA London
    Director
    42 Stradella Road
    SE24 9HA London
    EnglandBritishDirector7777210001
    MCMONIGALL, John Phillips
    Murrell Totters Lane
    Murrell Green
    RG27 8HX Hook
    Hampshire
    Director
    Murrell Totters Lane
    Murrell Green
    RG27 8HX Hook
    Hampshire
    BritishCompany Director10067900001
    MORGAN, Peter William Lloyd
    Cleeves
    Weydown Road
    GU27 1DT Haslemere
    Surrey
    Director
    Cleeves
    Weydown Road
    GU27 1DT Haslemere
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director9898660001
    PINNELL, David Peter
    7 Wildcroft Drive
    RG11 3HY Wokingham
    Berkshire
    Director
    7 Wildcroft Drive
    RG11 3HY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishSales & Manufacturing Executiv166768190001
    POWLICK, George
    78 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 1HS London
    Director
    78 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 1HS London
    AmericanDirector97276800001
    RADZIWILL, John
    Chalet Lynx
    Bissen
    FOREIGN Gstaad Bern
    3780
    Switzerland
    Director
    Chalet Lynx
    Bissen
    FOREIGN Gstaad Bern
    3780
    Switzerland
    SwitzerlandBritishBusinessman66708000004
    REISSNER, Roger Brian
    Greenbanks Wayside
    Chipperfield
    WD4 9JL Kings Langley
    Hertfordshire
    Director
    Greenbanks Wayside
    Chipperfield
    WD4 9JL Kings Langley
    Hertfordshire
    BritishEngineer31964060001

    ¿Tiene BALTIMORE CAPITAL PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 13 ene 2006
    Entregado el 20 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £49,350.00 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    £49,350.00.
    Personas con derecho
    • Cadogan Developments Limited
    Transacciones
    • 20 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 14 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of deposit
    Creado el 20 may 2005
    Entregado el 27 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Deposit initially of £470,000 credited to account designation 88062422 55-81-26 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 27 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 21 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creado el 12 jun 2003
    Entregado el 21 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit initially of euro 3,618,753.52 credited to account designation NX855632 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 21 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creado el 29 nov 2001
    Entregado el 07 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit initially of £775,000 credited to account designation 10053646 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of deposit
    Creado el 29 nov 2001
    Entregado el 07 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit initially of £745,000 credited to account designation 10053638 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 29 nov 2001
    Entregado el 07 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit initially of £720,000 credited to account designation 10053611 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 08 jun 2001
    Entregado el 27 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a rental guarantee in favour of api (no.10) limited for £625,000
    Breve descripción
    The sum of £625,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 10047181 55-81-26 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 27 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 21 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of deposit charge
    Creado el 26 abr 2001
    Entregado el 04 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monis obligations and liabilities from the company to the noteholders under the loan notes (both as defined)
    Breve descripción
    The deposit and all or any part of the right to repayment and any other rights or benefits accruing to or arising in connection with the deposit (all as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Noteholders from Time to Time Being as at the Date of the Instrumentsee Form 395
    Transacciones
    • 04 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 10 oct 2000
    Entregado el 16 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a rental guarantee in favour of michael o'sullivan and michael murphy for £IR2,850,000
    Breve descripción
    The sum of £2,430,000 together with interest accrued now or to be held by the national westminster bank PLC on an account numbered 10042075 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 21 may 1998
    Entregado el 26 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 14 nov 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 21 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Single debenture
    Creado el 09 sept 1993
    Entregado el 28 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 28 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed relating to deposit of money
    Creado el 20 ago 1993
    Entregado el 02 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money which kleinwort benson trustees limited is entitled to withdraw from a deposit account into which the sum of £15,000 was to be placed (as defined in this deed)
    Breve descripción
    The company' interest in all money from time to time standing to the credit of a deposit account in the joint names of the company and the landlord,kleinwort benson trustees limited with kleinwort benson investment management limited to which £15,000 paid by the companyto the chargee was to be credited pursuant to the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kleinwort Benson Trustees Limited
    Transacciones
    • 02 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene BALTIMORE CAPITAL PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    06 jun 2017Fecha de disolución
    21 mar 2011Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    William Guy Beach
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0