HOMESERVE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HOMESERVE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02648297 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HOMESERVE LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra HOMESERVE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Cable Drive Walsall WS2 7BN |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HOMESERVE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HOMESERVE PLC | 05 abr 2004 | 05 abr 2004 |
| SOUTH STAFFORDSHIRE GROUP PLC | 25 jun 1999 | 25 jun 1999 |
| SOUTH STAFFORDSHIRE WATER HOLDINGS PLC | 07 nov 1991 | 07 nov 1991 |
| SHARERESERVE PUBLIC LIMITED COMPANY | 24 sept 1991 | 24 sept 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HOMESERVE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HOMESERVE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 13 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 27 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 13 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOMESERVE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Sukanya Viswanathan como director el 16 feb 2026 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Marcello Del Raso Alvarado Davis como director el 10 feb 2026 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Marcello Del Raso Alvarado Davis como director el 18 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nishil Patel como director el 18 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Murski como director el 18 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sikander Rashid como director el 18 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 102 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Lucas Sim como director el 10 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mark Murski como director el 04 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Edward Bolus como director el 22 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard David Harpin como director el 31 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2024 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 99 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 109 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2024 au 31 dic 2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Jonathan Bower como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Taylor Hall como director el 31 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 33 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Lucas Sim como director el 17 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Rusin como director el 15 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Notification de Hestia Bidco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 ene 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 feb 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HOMESERVE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUGHAN, Anna | Secretario | Homeserve Plc Cable Drive WS2 7BN Walsall Homeserve Plc England | British | 53071850001 | ||||||
| BOLUS, Edward | Director | Cable Drive Walsall WS2 7BN | England | British | 307477530001 | |||||
| CLEMMOW, Alexander Ross | Director | Cable Drive Walsall WS2 7BN | England | British | 281176610001 | |||||
| HALL, Taylor | Director | Cable Drive Walsall WS2 7BN | England | Canadian | 307536440001 | |||||
| MONTESI, Gabriele | Director | One Canada Square E14 5AA London Level 25 England | England | Italian | 247894490002 | |||||
| PATEL, Nishil | Director | One Canada Square E14 5AA London Level 25 England | England | British | 342736770001 | |||||
| VISWANATHAN, Sukanya | Director | Cable Drive Walsall WS2 7BN | England | Indian | 345440240001 | |||||
| COATHUP, Stephen Paul | Secretario | 60 Wychwood Avenue Knowle B93 9DQ Solihull West Midlands | British | 6346040001 | ||||||
| NASH, Andrew | Secretario | Rutland House Chancery Mews B60 2DH Bromsgrove Worcestershire | British | 103516750001 | ||||||
| PAGE, Adrian Peter | Secretario | 11 Shadows Lane Congerstone CV13 6NF Nuneaton Warwickshire | British | 50576960001 | ||||||
| POWELL, Christopher Gary | Secretario | 11 Lords Drive St George TF2 9UE Telford Salop | British | 125639870001 | ||||||
| THOMAS, Caroline Emma Roberts | Secretario | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | 154322040001 | ||||||
| WHITTY, Brian Howard | Secretario | Ruxley House Rowney Green Lane Rowney Green B48 7QF Alvechurch Worcestershire | British | 36622750002 | ||||||
| BELK, Andrew John | Director | Pen Plannau Moelfre SY10 7QL Llansilin North Wales | British | 65603000003 | ||||||
| BENNETT, Martin John | Director | Homeserve Plc Cable Drive WS2 7BN Walsall Homeserve Plc England | United Kingdom | British | 220592220001 | |||||
| BOWER, David Jonathan | Director | Cable Drive WS2 7BN Walsall Homeserve Plc West Midlands England | England | British | 132462170002 | |||||
| BREEN, Thomas | Director | Cable Drive Walsall WS2 7BN | Ireland | Irish | 279209820001 | |||||
| BURY, Lindsay Claude Neils | Director | Millichope Park Munslow SY7 9HA Craven Arms Shropshire | United Kingdom | British | 67103750001 | |||||
| CARLISLE, Ian | Director | The Clock House West End Road Box End MK43 8RT Kempston Rural Bedfordshire | England | British | 146715900001 | |||||
| CARPENTER, James Montagu | Director | Holbeache Lodge Trimpley DY12 1PB Bewdley Worcestershire | British | 6346080001 | ||||||
| CHIPPENDALE, Ian Hugh | Director | Cable Drive WS2 7BN Walsall Homeserve Plc West Midlands England | England | British | 10033650008 | |||||
| COATHUP, Stephen Paul | Director | 60 Wychwood Avenue Knowle B93 9DQ Solihull West Midlands | British | 6346040001 | ||||||
| CORBETT, Richard Panton | Director | 24 Chapel Street SW1X 7BY London | United Kingdom | British | 7010710001 | |||||
| DAVID, Stella Julie | Director | Cable Drive Walsall WS2 7BN | United Kingdom | British | 146769220001 | |||||
| DAVIS, Marcello Del Raso Alvarado | Director | One Canada Square E14 5AA London Level 25 England | England | British | 342736870001 | |||||
| FITZMAURICE, Edward Martin | Director | Cable Drive WS2 7BN Walsall Homeserve Plc West Midlands England | England | Irish | 193071510002 | |||||
| FLORSHEIM, Jonathan Joseph | Director | Homeserve Plc Cable Drive WS2 7BN Walsall Homeserve Plc England | United Kingdom | British,German | 76209190001 | |||||
| FORD, Johnathan Richard | Director | Cable Drive WS2 7BN Walsall Homeserve Plc West Midlands England | England | British | 270740480001 | |||||
| GIBSON, John Michael Barry | Director | WS2 7BN Walsall Cable Drive England | England | British | 82660110009 | |||||
| GREMILLON, Olivier Daniel Lucien | Director | Cable Drive Walsall WS2 7BN | Denmark | French | 257065720002 | |||||
| HARLEY, Robert Ian | Director | Little Brook End Farm Holdings Lane Kempsey WR5 3LF Worcester | British | 42785040001 | ||||||
| HARPIN, Richard David | Director | Homeserve Plc Cable Drive WS2 7BN Walsall Homeserve Plc England | England | British | 34254010004 | |||||
| HARRIS, John Richard | Director | 15 Stivichall Croft CV3 6GP Coventry Warwickshire | British | 6346110001 | ||||||
| HAVEMANN, Christopher John | Director | Cable Drive Walsall WS2 7BN | United Kingdom | British | 174787140003 | |||||
| HUGHES, Roisin Jane Catherine | Director | Cable Drive Walsall WS2 7BN | England | British | 154275560001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HOMESERVE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hestia Bidco Limited | 04 ene 2023 | Canada Square E14 5AA London Level 25 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0