LBBA LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | LBBA LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02649186 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LBBA LIMITED?
- Comercio al por mayor no especializado de alimentos, bebidas y tabaco (46390) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra LBBA LIMITED?
Dirección de la sede social | 74 Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston Lancashire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LBBA LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LBBA LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2022 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2021 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Bako North Western (Group) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 oct 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cese del nombramiento de Joseph Hall como director el 01 jun 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr David James Yates como director el 01 jun 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Damien Patrick Ghee como director el 23 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Dianne Gillian Davies Walker como director el 23 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Janet Hill como director el 23 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cancelación total de la carga 026491860003 | 1 páginas | MR04 | ||
Cese del nombramiento de David James Yates como director el 29 ene 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Duncan Hindley como director el 29 ene 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Alan Michael Moore como director el 15 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Anthony Charles Sutton como director el 15 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2020 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 sept 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Damien Patrick Ghee como director el 25 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Anthony Charles Sutton como director el 25 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Philip Marshall como director el 18 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 sept 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de LBBA LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIRANI, Kirti | Secretario | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | 238694660001 | |||||||
YATES, David James | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | England | British | Baker | 234256550001 | ||||
GODSON, Richard William | Secretario | 34 Longdown Lane North Ewell Downs KT17 3JQ Epsom Surrey | British | 8416190002 | ||||||
PORTER, Richard Mark | Secretario | Roman Way Industrial Estate PR2 5BE Preston 74 Lancashire United Kingdom | British | 179763600001 | ||||||
TOMKINS, Christopher Newton | Secretario | Blunthall Butchers Farm Bournebridge Lane Stapleford Abbotts RM4 1LT Romford Essex | British | 70090880001 | ||||||
CARR, Janet | Director | 19 Little Heath Road Tilehurst RG3 5TY Reading Berkshire | United Kingdom | British | Master Baker | 3679820001 | ||||
CROWN, Alan James | Director | 43 Frederica Road Chingford E4 7AL London | United Kingdom | British | Managing Director | 30678990001 | ||||
EARL, Stuart Henry | Director | 37 Terminus Avenue TN39 3LY Bexhill On Sea Thursley Cottage East Sussex | England | British | Master Baker | 132238020001 | ||||
FLINT, Roy William | Director | Peel House 3 Beech Avenue CR2 0NN South Croydon Surrey | British | Master Baker/Managing Director | 24611510002 | |||||
GHEE, Damien Patrick | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 188064860001 | ||||
GOLDING, John William | Director | 5 Ellison Way ME8 7PL Gillingham Kent | United Kingdom | British | Master Baker | 132238050001 | ||||
GREENWOOD, Marcus Stephen | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancs Uk | England | British | Master Baker | 3171500001 | ||||
GROUT, Noel Maitland | Director | 307 The Chase SS7 3DN Thundersley Essex | British | Bakers Confectioner | 55544120001 | |||||
HALL, Joseph | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | England | British | Master Baker | 116832560004 | ||||
HALL, Joseph, Mroseph | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancs Uk | Great Britain | British | Master Baker | 156898720001 | ||||
HILL, Janet | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | England | British | Director | 215152220001 | ||||
HINDLEY, Duncan | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | England | British | Baker | 242490150001 | ||||
HUMBER, Terry James | Director | 8 Hampton Close SG2 8SP Stevenage Hertfordshire | British | Bakery Wholesale | 75405730001 | |||||
HUME, Dennis Walter | Director | 40 High Street CO9 2AP Halstead Essex | United Kingdom | British | Partner | 30679000002 | ||||
KELLETT, Peter William | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancs Uk | England | British | Master Baker | 21591330002 | ||||
MARSHALL, Philip | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | England | British | Master Baker | 88201900003 | ||||
MARSHALL, Philip | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancs Uk | United Kingdom | British | Master Baker | 88201900002 | ||||
MATTHEWS, Ian Dennis | Director | Morton House 3 Fore Street AL9 5AN Hatfield Hertfordshire | England | British | Baker | 3873500001 | ||||
MAYNE, Perry | Director | Penton Place 161 Thames Side TW18 2JH Staines Middlesex | United Kingdom | British | Bakery Owner | 42796800002 | ||||
MOORE, Alan Michael | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | England | British | Company Director | 241176010001 | ||||
PEARCE, Anthony Gifford | Director | Roding House Anstey SG9 0BZ Buntingford Hertfordshire | England | British | Company Director | 31838010001 | ||||
POWELL, David Upton | Director | 6 Swan Quay Lower Bath Lane PO16 0DX Fareham Hampshire | England | British | Director | 81291930002 | ||||
ROBINSON, David Arthur | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancs Uk | England | British | Master Baker | 1672240001 | ||||
SCOTT, Brian Leonard | Director | 20 Tomswood Road IG7 5QS Chigwell Essex | British | Master Baker | 11775800001 | |||||
SUTTON, Anthony Charles | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | United Kingdom | British | Hr Consultant | 55048490004 | ||||
TAYLOR, Martyn Anthony | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | England | British | Consultant | 190264080001 | ||||
TOMKINS, Christopher Newton | Director | Blunthall Butchers Farm Bournebridge Lane Stapleford Abbotts RM4 1LT Romford Essex | Uk | British | Master Baker | 70090880001 | ||||
WADGE, Leonard William James | Director | 4 Butlers Way Great Yeldham CO9 4QL Halstead Essex | British | Bakery Proprietor | 30678950002 | |||||
WALKER, Dianne Gillian Davies | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | England | British | British | 96695590001 | ||||
WATERFIELD, William John Edward | Director | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancs Uk | England | British | Master Baker | 11845530001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LBBA LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bako Group Limited | 01 mar 2018 | Roman Way Industrial Estate Ribbleton PR2 5BE Preston 74 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mr Joseph Hall | 06 abr 2016 | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mr Mark Robert Tomlinson | 06 abr 2016 | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mr Richard Mark Porter | 06 abr 2016 | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mr Andrew Hodgson | 06 abr 2016 | Roman Way Industrial Estate Longridge Road PR2 5BE Preston 74 Lancashire | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene LBBA LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 24 ago 2015 Entregado el 01 sept 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción All freehold and leasehold property vested in the company and all freehold and leasehold property of the company acquired after the date of the deed. All intellectual property now or in the future held by the company. For more details, please refer to the instrument. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 19 ago 2013 Entregado el 24 ago 2013 | Pendiente | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 18 sept 2002 Entregado el 30 sept 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0