JUNIPER (NO. 7) LIMITED

JUNIPER (NO. 7) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJUNIPER (NO. 7) LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02649336
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    • Explotación a cielo abierto de carbón (05102) / Explotación de minas y canteras

    ¿Dónde se encuentra JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Bdo Llp
    Central Square
    LS1 4DL 29 Wellington Street
    Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MINING SERVICES LTD25 may 200125 may 2001
    RJB MINING SERVICES LTD01 mar 199901 mar 1999
    R.J. BUDGE (PLANT) LIMITED10 dic 199110 dic 1991
    ELKINFIELD LIMITED27 sept 199127 sept 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2012
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2013
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta15 ago 2016
    Próxima declaración de confirmación vence29 ago 2016
    Vencido

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Restauración por orden judicial - anteriormente en liquidación voluntaria de acreedores

    3 páginasREST-CVL

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    21 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 oct 2017

    20 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5RU a C/O Bdo Llp Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL el 19 abr 2017

    2 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 oct 2016

    14 páginas4.68

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    9 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 oct 2015

    25 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 oct 2014

    21 páginas4.68

    Informe de progreso del administrador hasta 22 oct 2013

    11 páginas2.24B

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    1 páginas2.34B

    Resultado de la reunión de acreedores

    3 páginas2.23B

    Declaración de la propuesta del administrador

    62 páginas2.17B

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed mining services LTD\certificate issued on 12/08/13
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name12 ago 2013

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 28 jul 2013

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    17 páginas2.16B

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Domicilio social registrado cambiado de , Harworth Park, Blythe Road, Harworth,Doncaster, South Yorkshire.DN11 8DB el 17 jul 2013

    2 páginasAD01

    Cancelación total de la carga 10

    11 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 11

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 13

    4 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Central Square
    LS1 4DL 29 Wellington Street
    C/O Bdo Llp
    Leeds
    Secretario
    Central Square
    LS1 4DL 29 Wellington Street
    C/O Bdo Llp
    Leeds
    177797550001
    PARKIN, Derek
    Central Square
    LS1 4DL 29 Wellington Street
    C/O Bdo Llp
    Leeds
    Director
    Central Square
    LS1 4DL 29 Wellington Street
    C/O Bdo Llp
    Leeds
    EnglandBritish177788390001
    REED, Colin Frederick
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    Director
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish174641750001
    COLE, Richard Andrew
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    Secretario
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    British58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Secretario
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    British18761260001
    RHODES, Jeremy
    Harworth Park
    Blythe Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    Secretario
    Harworth Park
    Blythe Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    British169993380001
    HARWORTH SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro8223049
    172322000002
    BROCKSOM, David Graham
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish96416100003
    BUDGE, Richard John
    Wiseton Hall
    Wiseton
    DN10 5AE Doncaster
    South Yorkshire
    Director
    Wiseton Hall
    Wiseton
    DN10 5AE Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish27948060002
    COLE, Richard Andrew
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    Director
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    EnglandBritish58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Director
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish18761260001
    JARRETT, George William
    Wenvoe 51 Woodhill Road
    Collingham
    NG23 7NR Newark
    Nottinghamshire
    Director
    Wenvoe 51 Woodhill Road
    Collingham
    NG23 7NR Newark
    Nottinghamshire
    British30751750001
    JARRETT, Keith
    8 High Hoe Court
    S80 2PJ Worksop
    Nottinghamshire
    Director
    8 High Hoe Court
    S80 2PJ Worksop
    Nottinghamshire
    British30858770001
    LLOYD, Jonathan Simon
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    Director
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    United KingdomBritish95211330002
    MAWE, Christopher
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    Director
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    British99084660001
    MCPHIE, Gordon Allister
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    Director
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    British35904020001
    RHODES, Jeremy
    Harworth Park
    Blythe Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    Director
    Harworth Park
    Blythe Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    United KingdomBritish170032420001
    SPINDLER, Garold Ralph
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    Director
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    American101195530002
    TAYLOR, Simon Gareth
    Harworth Park
    Blythe Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    Director
    Harworth Park
    Blythe Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    United KingdomBritish160685730001
    TINSLEY, William Joseph
    23 Maypole Gardens
    Cawood
    YO8 3TG Selby
    North Yorkshire
    Director
    23 Maypole Gardens
    Cawood
    YO8 3TG Selby
    North Yorkshire
    EnglandEnglish114170770001
    WALTON, Colin Arthur
    Acre House Main Street
    Hougham
    Grantham
    Lincolnshire
    Director
    Acre House Main Street
    Hougham
    Grantham
    Lincolnshire
    British30858780001

    ¿Tiene JUNIPER (NO. 7) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 19 abr 2013
    Entregado el 20 abr 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Harworth Estates Mines Property Limited
    Transacciones
    • 20 abr 2013Registro de una carga (MR01)
    Deed of accession
    Creado el 26 abr 2012
    Entregado el 03 may 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the further company and the existing companies or any of them to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Its credit balances. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 03 may 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 30 may 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Chattel mortgage
    Creado el 09 jul 2009
    Entregado el 10 jul 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Caterpillar model 16H grader s/n 6ZJ00971. Caterpillar model 16H grader s/n 6ZJ00984. Caterpillar model 16H grader s/n 6ZJ00985 (for details of further chattels charged please refer to form 395) see image for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Leasing (UK) LTD
    Transacciones
    • 10 jul 2009Registro de un cargo (395)
    • 26 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    Creado el 30 ago 2006
    Entregado el 02 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights title and interest in sub leases in respect of goods comprised in hp leasing or hire agreements made or to be made between the chargee and the company together with the benefit of all collateral agreements guarantees indemnities negotiable instruments securities and insurance policies in connection with the agreements.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 06 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 30 ago 2006
    Entregado el 02 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £8,947,500.00 and all other monies due or to become due
    Breve descripción
    P0826 cat 789 dumptruck s/no 9ZC 118 date acquired 14.12.87 1987, P0827 cat 789 dumptruck s/no 9ZC 124 date acquired 14.12.87 1987, P0876 cat 789 dumptruck s/no 9ZC 160 date acquired 14.12.87 1987. for details of further goods charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 06 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 23/06/1999 and
    Creado el 01 mar 2006
    Entregado el 14 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 14 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 27 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 09 mar 2004
    Entregado el 25 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed charge all moneys standing to the credit of any account of the company all benefits due or arising to the company in respect of any and all contracts and policies of insurance taken out by or on behalf of the company or in which the company has an interest all of the companys book trade and other debts the companys goodwill by way of floating charge all of the companys assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transacciones
    • 25 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 10 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 mar 2004
    Entregado el 17 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all moneysstanding to the credit of any account, all benefits in respect of the insurances, all of the chargors' book, trade and other debts, all of the chargors' stock and inventory their goodwill and the bene. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Udt Leasing Limited
    Transacciones
    • 17 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 09 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 oct 1999
    Entregado el 19 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever to any finance party under each finance document to which that chargor is a party except for any obligation which if it were so included would result in this deed contravening section 151 of the companies act 1985 and to the ancillary bank under the ancillary facility in any capacity whatsoever
    Breve descripción
    All moneys standing to the credit of any account all benefits in respect of the insurances all book trade and other debts all stocks and inventory the goodwill and the benefit of all authorisations.
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia (As Agent)
    Transacciones
    • 19 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 09 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 dic 1994
    Entregado el 11 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the finance documents (as defined in the debenture) or any of them
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Chemical Investment Bank Limited (The "Security Trustee")as Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 11 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 11 dic 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 ago 1994
    Entregado el 18 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 30 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 15 dic 1993
    Entregado el 05 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 05 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 30 dic 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 22 feb 1992
    Entregado el 13 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the facilities agreement and/or the working capital facility letter and this deed
    Breve descripción
    See doc ref M411C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland("the Overdraft Bank")
    Transacciones
    • 13 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 22 feb 1992
    Entregado el 13 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the facilities agreement,the secured documents and this deed
    Breve descripción
    See doc ref M420C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(As Agent and Trustee for the Banks Under or Pursuant to the Facilities Agreement (as Defined)("the Agent")
    Transacciones
    • 13 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene JUNIPER (NO. 7) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    22 oct 2013Fin de la administración
    09 jul 2013Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Francis Graham Newton
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    Profesional
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    2
    FechaTipo
    15 abr 2019Fecha de disolución
    22 oct 2013Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Paul Bates
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Edward Terence Kerr
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire
    Profesional
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0