EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED

EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02649675
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o TEACHER STERN LLP
    31-41 Bedford Row
    WC1R 4JH London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KINGSHOLME LIMITED27 sept 199127 sept 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Nicholas Emlyn Peter Reid como director el 30 mar 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 27 sept 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2015

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Edmund Charles Mccann como director el 28 sept 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Francis Edward Boyd como director el 28 sept 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 oct 2015

    Estado de capital el 29 oct 2015

    • Capital: GBP 600
    SH01

    Cese del nombramiento de Brian Snoddon como director el 10 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Samuel James Harris como director el 10 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2014

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 sept 2014

    Estado de capital el 29 sept 2014

    • Capital: GBP 600
    SH01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2013

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 oct 2013

    Estado de capital el 10 oct 2013

    • Capital: GBP 600
    SH01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2012

    9 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2011 au 30 jun 2012

    1 páginasAA01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2010

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de * 10 Orange Street Haymarket London WC2H 7DQ* el 17 nov 2010

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2009

    8 páginasAA

    legacy

    7 páginasMG01

    ¿Quiénes son los directivos de EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CREIGHTON, David Andrew
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Secretario
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    British83528100001
    CREIGHTON, David Andrew
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Director
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Northern IrelandBritish83528100001
    KENNY, Timothy, Mr.
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    Secretario
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    Irish113651250001
    PATTISON, Eric
    10 Oakfern
    BT36 5FN Newtownabbey
    County Antrim
    Secretario
    10 Oakfern
    BT36 5FN Newtownabbey
    County Antrim
    British64178730001
    PINCUS, Barry Martin
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    Secretario
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    British46444010002
    BOYD, Francis Edward
    Rademon Estate
    60 Ballynahinch Road
    BT30 9HS Crossgar
    County Down
    Director
    Rademon Estate
    60 Ballynahinch Road
    BT30 9HS Crossgar
    County Down
    Northern IrelandNorthern Irish83528370002
    BYRNE, Philip Patrick
    29 Upper Merrion Street
    Dublin 2
    Republic Of Ireland
    Director
    29 Upper Merrion Street
    Dublin 2
    Republic Of Ireland
    Irish58604950001
    ELLIOTT, Acheson
    57 Craigdarragh Road
    BT19 1UB Helen's Bay
    County Down
    N. Ireland
    Director
    57 Craigdarragh Road
    BT19 1UB Helen's Bay
    County Down
    N. Ireland
    Northern IrelandBritish144365710001
    HARRIS, Samuel James
    2 The Pines
    Culcavy Road
    BT26 6NT Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    Director
    2 The Pines
    Culcavy Road
    BT26 6NT Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish158466790001
    KENNY, Timothy, Mr.
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    Director
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    IrelandIrish113651250001
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Director
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritish23621230001
    MCCANN, Edmund Charles
    9 Deramore Drive
    BT9 5JQ Belfast
    Northern Ireland
    Director
    9 Deramore Drive
    BT9 5JQ Belfast
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrish144512890001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Director
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    NOLAN, Geraldine
    620 Clonard Road
    IRISH Crumlin
    Dublin 12
    Ireland
    Director
    620 Clonard Road
    IRISH Crumlin
    Dublin 12
    Ireland
    Irish83257760001
    REID, Nicholas Emlyn Peter
    32 Rushvale Road
    BT39 9NN Ballyclare
    County Antrim
    Director
    32 Rushvale Road
    BT39 9NN Ballyclare
    County Antrim
    Northern IrelandBritish75236310001
    SMYTH, Noel Martin
    Lisieux Hall
    Murphystown Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Director
    Lisieux Hall
    Murphystown Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish91238420001
    SNODDON, Brian
    Culcavy Road
    BT26 6JD Hillsborough
    23
    County Down
    United Kingdom
    Director
    Culcavy Road
    BT26 6JD Hillsborough
    23
    County Down
    United Kingdom
    Northern IrelandBritish143738840001
    SNODDON, James Myrvan
    43 Carnreagh
    BT26 6LJ Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    Director
    43 Carnreagh
    BT26 6LJ Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    British143651570001
    STOUTZKER, Ian Isaac
    33 Wilton Crescent
    SW1X 8RX London
    Director
    33 Wilton Crescent
    SW1X 8RX London
    EnglandBritish2658490001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Brunswick (No 1) Limited
    Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    51-55
    Northern Ireland
    06 abr 2016
    Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    51-55
    Northern Ireland
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroNorthern Ireland
    Autoridad legalCompanies Act Ni
    Lugar de registroUk
    Número de registroNi429823
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge over deposits
    Creado el 08 oct 2010
    Entregado el 16 oct 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the mortgagor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit(s) being any sums deposited in the accounts and any other sum or sums which are from time to time deposited see image for full details.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) PLC (the Bank)
    Transacciones
    • 16 oct 2010Registro de un cargo (MG01)
    Security interest agreement
    Creado el 17 nov 2005
    Entregado el 30 nov 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    27,250,000 units in the unit trust known as bridge end unit trust, and the related rights,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transacciones
    • 30 nov 2005Registro de un cargo (395)
    Charge over deposits
    Creado el 18 oct 2005
    Entregado el 27 oct 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of a first fixed charge the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Aib Group UK PLC
    Transacciones
    • 27 oct 2005Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 jun 2004
    Entregado el 08 jul 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) PLC
    Transacciones
    • 08 jul 2004Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 12 mar 2004
    Entregado el 25 mar 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that l/h land known as the western section of the island site, hammersmith broadway, hammersmith, london t/no BGL10281, all that f/h land situated at fleet road, fleet in the county of hampshire and known as the hart centre t/nos HP389489, HP315793 and HP320745, and all that f/h land situated at market street and 21 and 23 the market place in newbury in the county of west berkshire and k/a the kennet centre t/no BK235120,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ulster Bank Limited and Ulster Bank Ireland Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 25 mar 2004Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 03 nov 2000
    Entregado el 13 nov 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from ewart property holdings limited (as borrower) to the chargee pursuant to a loan agreement in the amount of £23,000,000 dated 10TH february 1999 (as amended by a supplementary loan agreement dated 1ST november 1999) and/or any other finance documents (as defined in such loan agreement)
    Breve descripción
    Inclusive of property k/a wakefield house 9-15 stamford street london SE1 t/no;-SGL326607. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dunloe Ewart Finance B.V.
    Transacciones
    • 13 nov 2000Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 14 abr 2000
    Entregado el 27 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of (I) the borrower to the lender under the facility letter and the windsor dacility letter and (ii) of the company to the security trustee pursuant to the debenture
    Breve descripción
    Freehold property k/a wakefield house 9-15 stamford street london t/n SGL326607. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 27 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 14 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creado el 17 sept 1992
    Entregado el 02 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £8,400,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Breve descripción
    The f/h property k/as 9 to 15 (odd) stamford street in the l/b of southwark.t/n sgl 326607.floating charge all the company's property assets and rights whatsoever and wheresoever present and/or future.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transacciones
    • 02 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 25 abr 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0