GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED

GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02656702
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TEESRAN LIMITED25 nov 199125 nov 1991
    BIDEAWHILE ONE HUNDRED AND THREE LIMITED23 oct 199123 oct 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016

    1 páginasAA01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Jonathan Ross Brodie el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP el 23 oct 2015

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 12 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 oct 2015

    Estado de capital el 12 oct 2015

    • Capital: GBP 31
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 15 dic 2014

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 12 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 oct 2014

    Estado de capital el 13 oct 2014

    • Capital: GBP 31
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Elizabeth Catchpole como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Jon William Mortimore como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 12 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 oct 2013

    Estado de capital el 14 oct 2013

    • Capital: GBP 31
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 12 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Secretario
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147808030001
    BRODIE, Jonathan Ross
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Director
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritish62279790001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Director
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Director
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    ASH, Christine Ann
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    Secretario
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    British67480001
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Secretario
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    FRASER, Leslie Murray Fraser
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    Secretario
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    British53477320001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Secretario
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    British56953000002
    BWL SECRETARIES LIMITED
    20-32 Museum Street
    IP1 1HZ Ipswich
    Suffolk
    Secretario designado corporativo
    20-32 Museum Street
    IP1 1HZ Ipswich
    Suffolk
    900003770001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Director
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    England
    Director
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    England
    EnglandBritish98235420004
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Director
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    CAMERON, Alexander Douglas
    74 Old Barrack Road
    IP12 4ER Woodbridge
    Suffolk
    Director
    74 Old Barrack Road
    IP12 4ER Woodbridge
    Suffolk
    British5996730001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Director
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CLINTON, David
    213 Westburn Road
    AB2 4QF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    213 Westburn Road
    AB2 4QF Aberdeen
    Aberdeenshire
    British30279690001
    COMER, Geoffrey Stephen
    Robin Cottage
    Mill Street
    CO6 5AD Polstead
    Suffolk
    Director
    Robin Cottage
    Mill Street
    CO6 5AD Polstead
    Suffolk
    British56333770001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Director
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Director
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    Director
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United KingdomBritish207729000002
    WILSON, Peter George
    Acomb Mill
    The Ridings
    NE46 4PQ Hexham
    Northumberland
    Director
    Acomb Mill
    The Ridings
    NE46 4PQ Hexham
    Northumberland
    British37238690003
    BWL SECRETARIES LIMITED
    20-32 Museum Street
    IP1 1HZ Ipswich
    Suffolk
    Director designado corporativo
    20-32 Museum Street
    IP1 1HZ Ipswich
    Suffolk
    900003770001

    ¿Tiene GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge
    Creado el 09 ene 2009
    Entregado el 15 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £353,400.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The quadrangle lumely road horley t/no SY686086.
    Personas con derecho
    • Freehold Managers (Nominees) Limited
    Transacciones
    • 15 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 29 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 09 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 11 oct 2002
    Entregado el 15 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property situate at warwick castle park, stratford road, warwick and the hunting lodge, leafield farm, stratford road, warwick t/nos. WK256708 and WK261596. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 11 oct 2002
    Entregado el 15 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a land and buildings lying on the south east side of the crescent, nottingham t/no. NT244678. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 13 dic 2001
    Entregado el 15 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings to the north east side of albert road horley t/no: SY686086. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 29 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 14 jul 2000
    Entregado el 27 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 27 ene 1992
    Entregado el 29 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that the property k/as or being 1.894 acres of land at ransomes europark,nacton road,ipswich,suffolk.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 ene 1992Registro de un cargo (395)
    • 30 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 ene 1992
    Entregado el 29 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Please see M127C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 ene 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2015Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0