GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02656702 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Avant House 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TEESRAN LIMITED | 25 nov 1991 | 25 nov 1991 |
| BIDEAWHILE ONE HUNDRED AND THREE LIMITED | 23 oct 1991 | 23 oct 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Jonathan Ross Brodie el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP el 23 oct 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 15 dic 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Catchpole como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Jon William Mortimore como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretario | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | 147808030001 | |||||||
| BRODIE, Jonathan Ross | Director | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | England | British | 62279790001 | |||||
| LEWIS, Colin Edward | Director | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| SHARP, Giles Henry | Director | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||
| ASH, Christine Ann | Secretario | 18 Holbeck Avenue YO11 2XQ Scarborough North Yorkshire | British | 67480001 | ||||||
| COOPER, Hilary Joan | Secretario | 73 Stepney Road YO12 5BT Scarborough North Yorkshire | British | 51307940002 | ||||||
| FRASER, Leslie Murray Fraser | Secretario | 20 Franklin Street YO12 7JU Scarborough North Yorkshire | British | 53477320001 | ||||||
| GANDHI, Devendra | Secretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Secretario | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | British | 56953000002 | ||||||
| BWL SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 20-32 Museum Street IP1 1HZ Ipswich Suffolk | 900003770001 | |||||||
| BRODIE, Jonathan Ross | Director | Barn Cottage Moon Lane Dormansland RH7 6PD Lingfield Surrey | England | British | 62279790001 | |||||
| BROWN, Carole Elizabeth | Director | 11 Yelvertoft Road Crick NN6 7TR Northampton Barn 1 England England | England | British | 98235420004 | |||||
| BURNLEY, John Lewis | Director | Lantern Cottage Weeton Lane, Weeton LS17 0AN Leeds | England | British | 35543830001 | |||||
| CAMERON, Alexander Douglas | Director | 74 Old Barrack Road IP12 4ER Woodbridge Suffolk | British | 5996730001 | ||||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| CLINTON, David | Director | 213 Westburn Road AB2 4QF Aberdeen Aberdeenshire | British | 30279690001 | ||||||
| COMER, Geoffrey Stephen | Director | Robin Cottage Mill Street CO6 5AD Polstead Suffolk | British | 56333770001 | ||||||
| DIPRE, John Vivian | Director | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Director | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| FITZSIMMONS, Neil | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| GAFFNEY, David | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Director | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Director | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MCCABE, Kevin Charles | Director | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||
| MORTIMORE, Jon William | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent | United Kingdom | British | 207729000002 | |||||
| WILSON, Peter George | Director | Acomb Mill The Ridings NE46 4PQ Hexham Northumberland | British | 37238690003 | ||||||
| BWL SECRETARIES LIMITED | Director designado corporativo | 20-32 Museum Street IP1 1HZ Ipswich Suffolk | 900003770001 |
¿Tiene GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Charge | Creado el 09 ene 2009 Entregado el 15 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £353,400.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción The quadrangle lumely road horley t/no SY686086. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 09 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 11 oct 2002 Entregado el 15 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The property situate at warwick castle park, stratford road, warwick and the hunting lodge, leafield farm, stratford road, warwick t/nos. WK256708 and WK261596. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 11 oct 2002 Entregado el 15 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The property k/a land and buildings lying on the south east side of the crescent, nottingham t/no. NT244678. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 13 dic 2001 Entregado el 15 dic 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land and buildings to the north east side of albert road horley t/no: SY686086. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 14 jul 2000 Entregado el 27 jul 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 ene 1992 Entregado el 29 ene 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All that the property k/as or being 1.894 acres of land at ransomes europark,nacton road,ipswich,suffolk. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 ene 1992 Entregado el 29 ene 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Please see M127C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0