L & H DEVELOPMENTS LIMITED

L & H DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaL & H DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02662561
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LONDON AND HENLEY LIMITED17 mar 199317 mar 1993
    LONDON AND HENLEY INVESTMENTS LIMITED23 jun 199223 jun 1992
    TARGETRAISE LIMITED13 nov 199113 nov 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Timothy Andrew Roberts como director el 25 abr 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sarah Morrell Barzycki como director el 30 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nigel Mark Webb como director el 25 abr 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Charles John Middleton como director el 25 abr 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Bruce Michael James como director el 25 abr 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Jonathan Charles Mcnuff como director el 25 abr 2018

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de Lucinda Margaret Bell como director el 19 ene 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Nigel Mark Webb el 25 may 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mrs Lucinda Margaret Bell el 25 may 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mrs Sarah Morrell Barzycki el 25 may 2017

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de Christopher Michael John Forshaw como director el 05 abr 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Michael John Forshaw como director el 05 abr 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Michael John Forshaw como director el 05 abr 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ndiana Ekpo como secretario el 06 dic 2016

    1 páginasTM02

    Nombramiento de British Land Company Secretarial Limited como secretario el 06 dic 2016

    2 páginasAP04

    Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    4 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro8992198
    187856670001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish226746900001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Secretario
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    BURGESS, Graeme
    Bali Hai
    Cudham Lane North
    TN14 7RB Sevenoaks
    Kent
    Secretario
    Bali Hai
    Cudham Lane North
    TN14 7RB Sevenoaks
    Kent
    British102349020001
    CADER, Tariq Azad
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    Secretario
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    British42841550001
    EKPO, Ndiana
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Secretario
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Other138446320001
    KEARTON GEE, Frank Watts
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    Secretario
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    British16914130001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish32809050044
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Director
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    CADER, Tariq Azad
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    Director
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    British42841550001
    CARTER, Simon Geoffrey
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Director
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Director
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    COOK, Kevin William
    Oakcroft Redlands Lane
    Ewshot
    GU10 5AS Farnham
    Surrey
    Director
    Oakcroft Redlands Lane
    Ewshot
    GU10 5AS Farnham
    Surrey
    British16914120001
    ECCLES, Christopher John
    7 Grovenor Road
    Chiswick
    W41 3EJ London
    Director
    7 Grovenor Road
    Chiswick
    W41 3EJ London
    British61037210002
    ECCLES, Christopher John
    Salcombe Regis House
    Salcombe Regis
    EX10 0JH Sidmouth
    Devon
    Director
    Salcombe Regis House
    Salcombe Regis
    EX10 0JH Sidmouth
    Devon
    Great BritainBritish61037210003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Director
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Director
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish3079890002
    HAMILTON, Laura Louise
    5 Park Lodge
    Park Close
    SW1X 7PH London
    Director
    5 Park Lodge
    Park Close
    SW1X 7PH London
    American73545680001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Director
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    KEARTON GEE, Frank Watts
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    Director
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    EnglandBritish16914130001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Director
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MOORE, Albert Richard Jr
    5 Relton Mews
    SW7 1ET London
    Director
    5 Relton Mews
    SW7 1ET London
    Usa73545620001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Director
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritish41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Director
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritish35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Director
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritish79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritish63986410004
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish148183670001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    London And Henley Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 abr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene L & H DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 21 dic 2000
    Entregado el 05 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities due or to become due from the borrower or the company to the beneficiaries under the finance documents or otherwise on any current or other account whatever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Abbey National Treasury Services PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 05 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge debenture
    Creado el 19 jul 2000
    Entregado el 27 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and whether or not the chargee shall have been an original party to the relevant transaction
    Breve descripción
    By way of floating charge all the assets undertaking and property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 09 mar 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 18 dic 1997
    Entregado el 24 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge over the undertaking and all its property and assets present and future.
    Personas con derecho
    • Kleinwort Benson Development Capital Limitedas Security Trustee for the Security Beneficiaries (As Defined Therein)
    Transacciones
    • 24 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 14 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 27 jun 1997
    Entregado el 16 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 09 mar 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 26 jul 1995
    Entregado el 05 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in the deed
    Breve descripción
    Floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Kleinwort Benson Development Capital Limitedies as Defined Therein ("the Security Trustee")(As Security Trustee for the Security Beneficiar
    Transacciones
    • 05 ago 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 05 ago 1995Registro de un cargo (395)
    Floating charge
    Creado el 26 jul 1995
    Entregado el 28 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0