L & H DEVELOPMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | L & H DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02662561 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LONDON AND HENLEY LIMITED | 17 mar 1993 | 17 mar 1993 |
| LONDON AND HENLEY INVESTMENTS LIMITED | 23 jun 1992 | 23 jun 1992 |
| TARGETRAISE LIMITED | 13 nov 1991 | 13 nov 1991 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Cancelación total de la carga 6 | 4 páginas | MR04 | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Timothy Andrew Roberts como director el 25 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Sarah Morrell Barzycki como director el 30 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Nigel Mark Webb como director el 25 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Charles John Middleton como director el 25 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Bruce Michael James como director el 25 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Jonathan Charles Mcnuff como director el 25 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018 | 4 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Lucinda Margaret Bell como director el 19 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Nigel Mark Webb el 25 may 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Lucinda Margaret Bell el 25 may 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Sarah Morrell Barzycki el 25 may 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 3 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Christopher Michael John Forshaw como director el 05 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Michael John Forshaw como director el 05 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Michael John Forshaw como director el 05 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Ndiana Ekpo como secretario el 06 dic 2016 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de British Land Company Secretarial Limited como secretario el 06 dic 2016 | 2 páginas | AP04 | ||
Declaración de confirmación presentada el 13 nov 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 4 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Secretario | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
| BURGESS, Graeme | Secretario | Bali Hai Cudham Lane North TN14 7RB Sevenoaks Kent | British | 102349020001 | ||||||||||
| CADER, Tariq Azad | Secretario | 19 Brookview Road Streatham SW16 6UA London | British | 42841550001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Secretario | Chislehurst Road BR5 1NR Petts Wood 182 Kent United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| KEARTON GEE, Frank Watts | Secretario | The Windrush Stoke Row Road RG9 5JD Peppard Common Oxfordshire | British | 16914130001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Director | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| CADER, Tariq Azad | Director | 19 Brookview Road Streatham SW16 6UA London | British | 42841550001 | ||||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Director | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Director | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||||||
| COOK, Kevin William | Director | Oakcroft Redlands Lane Ewshot GU10 5AS Farnham Surrey | British | 16914120001 | ||||||||||
| ECCLES, Christopher John | Director | 7 Grovenor Road Chiswick W41 3EJ London | British | 61037210002 | ||||||||||
| ECCLES, Christopher John | Director | Salcombe Regis House Salcombe Regis EX10 0JH Sidmouth Devon | Great Britain | British | 61037210003 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Director | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| GUNSTON, Michael Ian | Director | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | 3079890002 | |||||||||
| HAMILTON, Laura Louise | Director | 5 Park Lodge Park Close SW1X 7PH London | American | 73545680001 | ||||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Director | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| KEARTON GEE, Frank Watts | Director | The Windrush Stoke Row Road RG9 5JD Peppard Common Oxfordshire | England | British | 16914130001 | |||||||||
| METLISS, Cyril | Director | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||||||
| MOORE, Albert Richard Jr | Director | 5 Relton Mews SW7 1ET London | Usa | 73545620001 | ||||||||||
| RITBLAT, John, Sir | Director | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | 41694870001 | |||||||||
| RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Director | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | 35758050004 | |||||||||
| ROBERTS, Graham Charles | Director | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | 79807180002 | |||||||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 63986410004 | |||||||||
| SMITH, Stephen Paul | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 148183670001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London And Henley Limited | 06 abr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Tiene L & H DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 21 dic 2000 Entregado el 05 ene 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies and liabilities due or to become due from the borrower or the company to the beneficiaries under the finance documents or otherwise on any current or other account whatever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge debenture | Creado el 19 jul 2000 Entregado el 27 jul 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and whether or not the chargee shall have been an original party to the relevant transaction | |
Breve descripción By way of floating charge all the assets undertaking and property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 18 dic 1997 Entregado el 24 dic 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Floating charge over the undertaking and all its property and assets present and future. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 27 jun 1997 Entregado el 16 jul 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 26 jul 1995 Entregado el 05 ago 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in the deed | |
Breve descripción Floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 26 jul 1995 Entregado el 28 jul 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0