TOM COBLEIGH LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTOM COBLEIGH LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02673413
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TOM COBLEIGH LIMITED?

    • Pubs y bares (56302) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra TOM COBLEIGH LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Kroll Advisory Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TOM COBLEIGH LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta01 ene 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TOM COBLEIGH LIMITED?

    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta19 dic 2023

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TOM COBLEIGH LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    43 páginasLIQ13

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Destitución del liquidador por orden judicial

    19 páginasLIQ10

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 10 jun 2024

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Domicilio social registrado cambiado de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a C/O Kroll Advisory Ltd the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG el 20 jun 2024

    3 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 19 dic 2023 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Memorándum y Estatutos

    10 páginasMA

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Amount arising from reduction credited to the profit and loss reserves 17/11/2023
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 22 nov 2023

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    103 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1

    Cese del nombramiento de Matthew Robert Lee como director el 31 mar 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Simon Nicholas D'cruz como director el 31 mar 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 19 dic 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 ene 2022

    14 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de TOM COBLEIGH LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KESWICK, Lindsay Anne
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Kroll Advisory Ltd
    Secretario
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Kroll Advisory Ltd
    207524280001
    D'CRUZ, Simon Nicholas
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Kroll Advisory Ltd
    Director
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Kroll Advisory Ltd
    United KingdomBritish242723610001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    British67008750001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592830001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secretario
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    Jubilee Lodge 7 Walnut Grove
    East Bridgford
    NG13 8NS Nottingham
    Secretario
    Jubilee Lodge 7 Walnut Grove
    East Bridgford
    NG13 8NS Nottingham
    British24300100006
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172444990001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181021380001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Secretario
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    British34191470001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Secretario
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Secretario
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    British34048840002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    BOND, David Simon
    18 Grove Farm Close
    Brimington
    S43 Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    18 Grove Farm Close
    Brimington
    S43 Chesterfield
    Derbyshire
    British55811660001
    CORMICK, Charles Bruce Arthur
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    Director
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    United KingdomBritish17946190001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish67008750001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GARRETT, John Francis
    33 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    33 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British10858710001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    HALL, Johnathan Rufus
    47 Crouch Hall Lane
    Redbourn
    AL3 7EU St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    47 Crouch Hall Lane
    Redbourn
    AL3 7EU St. Albans
    Hertfordshire
    British67008690001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Director
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    LAVINGTON, Michael John
    16 Devonshire Lane
    07945 Mendham
    New Jersey
    Usa
    Director
    16 Devonshire Lane
    07945 Mendham
    New Jersey
    Usa
    American56608760002
    LEE, Matthew Robert
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Director
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritish286667680001
    MAPP, Derek
    Dunston Hole Farm Dunston Road
    Newbold
    S41 9RL Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    Dunston Hole Farm Dunston Road
    Newbold
    S41 9RL Chesterfield
    Derbyshire
    British12473610001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Director
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MCQUARTER, Mark
    14 Townsend Drive
    AL3 5RQ St Albans
    Hertfordshire
    Director
    14 Townsend Drive
    AL3 5RQ St Albans
    Hertfordshire
    British57915140001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TOM COBLEIGH LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06 abr 2016
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3982443
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene TOM COBLEIGH LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    10 jun 2024Inicio de la liquidación
    13 sept 2025Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Paul David Williams
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Edward Robert Bines
    Kroll Advisory Ltd The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    Kroll Advisory Ltd The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Benjamin John Wiles
    C/O Kroll Advisory Ltd, The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Profesional
    C/O Kroll Advisory Ltd, The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0