BLENDPACK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBLENDPACK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02675678
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BLENDPACK LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra BLENDPACK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BLENDPACK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BLENDPACK LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLENDPACK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    A3N3M43M

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2014

    5 páginasAA
    A3N8UC6P

    Déclaration annuelle établie au 13 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 dic 2014

    Estado de capital el 22 dic 2014

    • Capital: GBP 30,004
    SH01
    X3NATKUZ

    Déclaration annuelle établie au 13 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    X2YZ5Z81

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2013

    6 páginasAA
    A2NPLDRM

    Déclaration annuelle établie au 13 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    X1O4SKF7

    Cambio de datos del director Mr Stephen Stuart Solomon Conway el 12 dic 2012

    2 páginasCH01
    X1O4SKEZ

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2012

    6 páginasAA
    L1NMXQ02

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    8 páginasAA
    L0ZVATYQ

    Déclaration annuelle établie au 13 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    X0O2S25N

    Nombramiento de Mr Allan William Porter como secretario

    1 páginasAP03
    XDRYMTES

    Cese del nombramiento de George Angus como secretario

    1 páginasTM02
    XDRY7TED

    Déclaration annuelle établie au 13 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    XDPRSQIQ

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    11 páginasAA
    LENHUPTF

    Déclaration annuelle établie au 13 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    X2D9VF1W

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    11 páginasAA
    AFPLGEA3

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    11 páginasAA
    LAEIR6YM

    legacy

    3 páginas363a
    X8B0V56M

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2007

    12 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2006

    12 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2005

    10 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de BLENDPACK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PORTER, Allan William
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    Secretario
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    159485530001
    CONWAY, Stephen Stuart Solomon
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    Director
    3rd Floor
    Sterling House Langston Road
    IG10 3TS Loughton
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director197472860001
    ANGUS, George David
    30 Cause End Road
    MK43 9DB Wootton
    Bedfordshire
    Secretario
    30 Cause End Road
    MK43 9DB Wootton
    Bedfordshire
    British6279030001
    ANGUS, George David
    30 Cause End Road
    MK43 9DB Wootton
    Bedfordshire
    Secretario
    30 Cause End Road
    MK43 9DB Wootton
    Bedfordshire
    British6279030001
    DAVIS, Marilyn Irene
    7 Harley House
    Upper Harley Street
    NW1 4PR London
    Secretario
    7 Harley House
    Upper Harley Street
    NW1 4PR London
    British22607830002
    KANTHARIA, Hazra Yakub
    72 Windsor Road
    E7 0QY London
    Secretario
    72 Windsor Road
    E7 0QY London
    BritishSales Assistant65702750001
    ZIPRIN, Geoffrey Charles
    The Old Carters House
    53 Chenies Village
    WD3 6EQ Bucks
    Secretario designado
    The Old Carters House
    53 Chenies Village
    WD3 6EQ Bucks
    British900001590001
    AZOUZ, Edward
    Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PH London
    30
    Director
    Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PH London
    30
    United KingdomBritishChartered Accountant50527240001
    CONWAY, Stephen Stuart
    4a Lyndhurst Road
    Hampstead
    NW3 5PX London
    Director
    4a Lyndhurst Road
    Hampstead
    NW3 5PX London
    BritishCompany Director51777440002
    DAVIS, Lewis John
    9 Montagu Square
    W1H 2LB London
    Director
    9 Montagu Square
    W1H 2LB London
    EnglandBritishCo Director146476190001
    KANTHARIA, Hazra Yakub
    72 Windsor Road
    E7 0QY London
    Director
    72 Windsor Road
    E7 0QY London
    BritishSales Assistant65702750001
    PATEL, Yunus Ibrahim
    72 Windsor Road
    E7 0QY London
    Director
    72 Windsor Road
    E7 0QY London
    BritishCompany Director65953610001
    POTTER, Irene
    55 Peel Place
    Clayhall Avenue
    IG5 0PT Ilford
    Essex
    Director designado
    55 Peel Place
    Clayhall Avenue
    IG5 0PT Ilford
    Essex
    British900001600001

    ¿Tiene BLENDPACK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 19 oct 2004
    Entregado el 22 oct 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    548-550 chiswick high road, chiswick and land at the rear of 548/560 chiswick high road, london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 oct 2004Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 19 oct 2004
    Entregado el 22 oct 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 oct 2004Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 11 abr 2000
    Entregado el 14 abr 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    548/550 chiswick high road W4.
    Personas con derecho
    • Galliard Homes Limited
    Transacciones
    • 14 abr 2000Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 29 jul 1999
    Entregado el 06 ago 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property at 548/550 chiswick high road london t/n MX80948 and MX155971 and all fixtures fittings and machinery the goodwill of the business the proceeds of sale all rent and other money and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Irish Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 06 ago 1999Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 29 jul 1999
    Entregado el 06 ago 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Irish Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 06 ago 1999Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 05 mar 1999
    Entregado el 13 mar 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transacciones
    • 13 mar 1999Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 05 mar 1999
    Entregado el 13 mar 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a 548 and 550 chiswick high road hounslow london W4 and the proceeds of sale thereof and all compensation or grants payable or interest under any lease or tenancy assignment of such interest of the company in the prioperty that are not capable of being legally charged by way of floating charge all property and assets a charge over shares assignment by way of security,the benefit of all guarantees and warranties see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transacciones
    • 13 mar 1999Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0