TELESHOP SERVICES LIMITED

TELESHOP SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTELESHOP SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02677693
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TELESHOP SERVICES LIMITED?

    • Comercio al por mayor no especializado de alimentos, bebidas y tabaco (46390) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FINISHGOOD LIMITED15 ene 199215 ene 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta27 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    21 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 15 dic 2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium account cancelled. Sum of £450,056 be credited to the p/l 07/12/2015
    RES13

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 1

    5 páginasMR05

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Cese del nombramiento de Christopher Nicholas Martin como director el 14 sept 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Timothy Kenny como director el 14 sept 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Thomas Codd como director el 14 sept 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Thomas Codd como secretario el 14 sept 2015

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Jonathan Paul Prentis como director el 14 sept 2015

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de Musgrave House Widewater Place Moorhall Road Harefield Middlesex UB9 6NS a Equity House Irthlingborough Road Wellingborough Northamptonshire NN8 1LT el 29 sept 2015

    1 páginasAD01

    Renuncia de un auditor

    3 páginasAA03

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 dic 2014

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 ene 2015

    Estado de capital el 15 ene 2015

    • Capital: GBP 447,187
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    11 páginasAA

    Cese del nombramiento de Donal Horgan como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 15 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 ene 2014

    Estado de capital el 16 ene 2014

    • Capital: GBP 447,187
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PRENTIS, Jonathan Paul
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Director
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish177693990001
    CLAYTON, Ian David Keith
    11 The Court
    Marine Gate Promenade
    PR9 0EG Southport
    Secretario
    11 The Court
    Marine Gate Promenade
    PR9 0EG Southport
    British18285200002
    CODD, David Thomas, Mr.
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Secretario
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    182404910001
    DUNLEA, Aidan Finbar
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secretario
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Irish108011300001
    HARE, Richard Warren
    Sunnyside Main Street
    Gawcott
    MK18 4HZ Buckingham
    Buckinghamshire
    Secretario
    Sunnyside Main Street
    Gawcott
    MK18 4HZ Buckingham
    Buckinghamshire
    British2955620006
    MORGAN, David George
    7 Firs Gate
    HG2 9HE Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    7 Firs Gate
    HG2 9HE Harrogate
    North Yorkshire
    British16133400001
    O'FLYNN, David
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Secretario
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Irish123363960001
    TREBBLE, Christopher John
    36 Stembridge Way
    Norton Fitzwarren
    TA2 6SX Taunton
    Somerset
    Secretario
    36 Stembridge Way
    Norton Fitzwarren
    TA2 6SX Taunton
    Somerset
    British51754910001
    WIRTH, Julie Ann
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Secretario
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    British114305580001
    BARNETT, Louise Annabel
    Anscott House
    17 Nottingham Road
    LE65 1DJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Director
    Anscott House
    17 Nottingham Road
    LE65 1DJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British54609000001
    BARNETT, Louise Annabel
    Anscott House
    17 Nottingham Road
    LE65 1DJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Director
    Anscott House
    17 Nottingham Road
    LE65 1DJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British54609000001
    CODD, David Thomas, Mr.
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Director
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    IrelandIrish182392430001
    DAVIES, Colin Ernest
    The Granary
    Escrick Road
    YO19 6BQ York
    North Yorkshire
    Director
    The Granary
    Escrick Road
    YO19 6BQ York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish78759470002
    DUNLEA, Aidan Finbar
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Irish108011300001
    ELLIS, Peter Brian
    11 Hanover Close St Botolphs View
    Barton Seagrave
    NN15 6GH Kettering
    Northamptonshire
    Director
    11 Hanover Close St Botolphs View
    Barton Seagrave
    NN15 6GH Kettering
    Northamptonshire
    British45029930001
    HORGAN, Donal Patrick
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Director
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    IrelandIrish163398920001
    HYSON, Martin John
    Poplar Lane
    RG10 0DJ Hurst Reading
    White Rose Cottage
    Berkshire
    Director
    Poplar Lane
    RG10 0DJ Hurst Reading
    White Rose Cottage
    Berkshire
    United KingdomBritish128460840001
    KENNY, Timothy, Mr.
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Director
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    IrelandIrish113651250001
    MARTIN, Christopher Nicholas
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Director
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish48484090003
    MORGAN, David George
    7 Firs Gate
    HG2 9HE Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    7 Firs Gate
    HG2 9HE Harrogate
    North Yorkshire
    British16133400001
    O'FLYNN, David, Mr.
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Director
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    IrelandIrish163739400001
    O'FLYNN, David
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Director
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Irish123363960001
    OLD, Douglas Henry
    Clevedale
    Green Lane, Collingham
    LS22 5DE Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    Clevedale
    Green Lane, Collingham
    LS22 5DE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish78026400001
    PYE, James Francis
    11 Neville Crescent
    MK43 8JE Bromham
    Bedfordshire
    Director
    11 Neville Crescent
    MK43 8JE Bromham
    Bedfordshire
    British99123350001
    PYPER, Simon John
    160 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1NG London
    Director
    160 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1NG London
    British108173190001
    RIGBY, Graham Lakin
    Magnolia Cottage 4 Fulmer Place Farm
    SL3 6HP Fulmer
    Buckinghamshire
    Director
    Magnolia Cottage 4 Fulmer Place Farm
    SL3 6HP Fulmer
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish74211400002
    SMITH, Philip Anthony
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Director
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    EnglandBritish233299960001
    TAYLOR, Michael John
    The Old Parsonage
    Nether Winchendon
    HP18 0EA Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    The Old Parsonage
    Nether Winchendon
    HP18 0EA Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish122666080001
    TREBBLE, Christopher John
    36 Stembridge Way
    Norton Fitzwarren
    TA2 6SX Taunton
    Somerset
    Director
    36 Stembridge Way
    Norton Fitzwarren
    TA2 6SX Taunton
    Somerset
    British51754910001
    WIRTH, Julie Ann
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Director
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    EnglandBritish114305580002

    ¿Tiene TELESHOP SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 25 ene 1998
    Entregado el 02 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all book and other debts both present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance in relation to such book and other debts; by way of first floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future including the assets comprised in the fixed charges to the extent that such fixed assets shall for any reason be ineffective.
    Personas con derecho
    • Euro Sales Finance PLC
    Transacciones
    • 02 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 02 ago 1994
    Entregado el 05 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 31 mar 1993
    Entregado el 09 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 31ST march 1993
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lancashire Enterprises Venture Fund
    Transacciones
    • 09 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 31 mar 1993
    Entregado el 06 abr 1993
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    The performance of the tenant's obligations under the lease of even date and this deed to the chargee
    Breve descripción
    £15,000.00 placed in a separate account with the landlord'sbankers.
    Personas con derecho
    • Commission for the New Towns
    Transacciones
    • 06 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2015Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0