ACCOLADE WINES EUROPE NO 10 LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ACCOLADE WINES EUROPE NO 10 LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02684701 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ACCOLADE WINES EUROPE NO 10 LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ACCOLADE WINES EUROPE NO 10 LIMITED?
Dirección de la sede social | Accolade House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Surrey United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ACCOLADE WINES EUROPE NO 10 LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
ACCOLADE BRANDS LIMITED | 31 ene 2011 | 31 ene 2011 |
CONSTELLATION EUROPE 9 LIMITED | 23 mar 2010 | 23 mar 2010 |
R N COATE & CO LIMITED | 11 mar 1992 | 11 mar 1992 |
BEFORECASE LIMITED | 06 feb 1992 | 06 feb 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ACCOLADE WINES EUROPE NO 10 LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ACCOLADE WINES EUROPE NO 10 LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de James David Lousada como director el 05 sept 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Gavin Stuart Brockett el 31 jul 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gavin Stuart Brockett como director el 09 mar 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jeremy Alexander Stevenson como director el 09 mar 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed accolade brands LIMITED\certificate issued on 14/03/12 | 2 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Troy Christensen el 06 mar 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 feb 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2011 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ene 2011 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jeremy Stevenson como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Esther Clothier como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jeremy Stevenson como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jeremy Stevenson como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Hughes como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Hughes como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Hughes como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Hughes como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr James David Lousada el 27 jun 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David John Hughes el 27 jun 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr David John Hughes el 27 jun 2011 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ACCOLADE WINES EUROPE NO 10 LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOTHIER, Esther | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 162011780001 | |||||||
STEVENSON, Jeremy | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 161854820001 | |||||||
BROCKETT, Gavin Stuart | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | South African | Accountant | 167554030002 | ||||
CHRISTENSEN, Troy | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | American | Company Director | 130789730003 | ||||
STEVENSON, Jeremy Alexander | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Solicitor | 161846280001 | ||||
COLQUHOUN, Anne Therese | Secretario | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | Company Secretary | 28396500005 | |||||
HUGHES, David John | Secretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 157429070002 | |||||||
MALHOTRA, Deepak Kumar | Secretario | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | British | Solicitor | 69554640002 | |||||
WARREN, David Maxwell | Secretario | Weir House 1 Heol Isaf Radyr CF15 8AF Cardiff South Glamorgan | British | 44371280001 | ||||||
NQH (CO SEC) LIMITED | Secretario designado corporativo | Narrow Quay House Narrow Quay BS1 4AH Bristol | 900001160001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BURGE, Alan | Director | 10 Claremont Gardens Hallatrow BS18 5EY Bristol Avon | British | 57689110001 | ||||||
COLQUHOUN, Anne Therese | Director | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | Company Secretary | 28396500005 | ||||
CREIGHTON, Thomas Hugh | Director | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | Accountant | 157727790001 | ||||
ETHERIDGE, Hugh Charles | Director | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | Director | 1491130002 | ||||
GLENNIE, Helen Margaret | Director | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 137615160001 | ||||
HODGES, Nigel Ian | Director | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | Business Development Executive | 75692570001 | |||||
HUGHES, David John | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Accountant | 157415150002 | ||||
KLEIN, David | Director | 45 Princes Road The Alberts TW10 6DQ Richmond Surrey | American | Company Director | 119928070001 | |||||
LOUSADA, James David | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | England | British | Company Director | 152222000001 | ||||
MALHOTRA, Deepak Kumar | Director | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Artington Guildford Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 69554640002 | ||||
PETERS, Richard David | Director | Rose Cottage, Upper House Lane Shamley Green GU5 0SX Guildford Surrey | United Kingdom | British | Director | 60630980002 | ||||
STEVENSON, Jeremy Alexander | Director | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | Australia | Australian | Solicitor | 161846280001 | ||||
WARREN, David Maxwell | Director | Weir House 1 Heol Isaf Radyr CF15 8AF Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 44371280001 | |||||
WILKINSON, John Leonard | Director | Shell Cottage The Street Chilcompton BA3 4HB Bath Avon | British | 42968490001 | ||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
NQH LIMITED | Director designado corporativo | Narrow Quay House Narrow Quay BS1 4AH Bristol | 900001150001 |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0