THE FRENCH APARTMENTS RESIDENTS' ASSOCIATION LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE FRENCH APARTMENTS RESIDENTS' ASSOCIATION LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 02685720 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE FRENCH APARTMENTS RESIDENTS' ASSOCIATION LIMITED?
- Administración de la propiedad de los residentes (98000) / Actividades de los hogares como empleadores; actividades de producción de bienes y servicios no diferenciadas de los hogares para uso propio
¿Dónde se encuentra THE FRENCH APARTMENTS RESIDENTS' ASSOCIATION LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2 Chartland House Old Station Approach KT22 7TE Leatherhead England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE FRENCH APARTMENTS RESIDENTS' ASSOCIATION LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE FRENCH APARTMENTS RESIDENTS' ASSOCIATION LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 ene 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 08 feb 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 ene 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE FRENCH APARTMENTS RESIDENTS' ASSOCIATION LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Yehudi Webster como director el 27 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2025 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Yehudi Webster como director el 29 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2024 | 3 páginas | AA | ||
Nombramiento de Miss Chalene Angelique Hanson como director el 31 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Stephen Brill como director el 01 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2023 | 3 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Joshua Viggiani como director el 07 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Chalene Hanson como director el 07 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de David Martin como director el 01 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Miss Chalene Hanson como director el 09 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Hes Estate Management Limited como secretario el 01 oct 2022 | 2 páginas | AP04 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 5 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Provident House Burrell Row Beckenham BR3 1AT England a 2 Chartland House Old Station Approach Leatherhead KT22 7TE el 03 oct 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Vfm Procurement Limited como secretario el 30 sept 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2021 | 3 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Stephen Brill como director el 03 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Antony Palmer como director el 03 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Caroline Brain como director el 12 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Marco D'ascoli como director el 22 sept 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE FRENCH APARTMENTS RESIDENTS' ASSOCIATION LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HES ESTATE MANAGEMENT LIMITED | Secretario corporativo | Old Station Approach KT22 7TE Leatherhead 2 Chartland House England |
| 255372460001 | ||||||||||
| D'ASCOLI, Marco | Director | Chartland House Old Station Approach KT22 7TE Leatherhead 2 England | England | Italian | 287846350001 | |||||||||
| HANSON, Chalene Angelique | Director | Chartland House Old Station Approach KT22 7TE Leatherhead 2 England | England | British | 303376180001 | |||||||||
| VIGGIANI, Joshua | Director | Chartland House Old Station Approach KT22 7TE Leatherhead 2 England | England | British | 315655170001 | |||||||||
| ANDERTON, Richard John Bowman | Secretario | 29 Rutland Street Kensington SW7 1EJ London | British | 3543040004 | ||||||||||
| BALCHIN, Mark Nicholas | Secretario | 6 Fleming Close GU14 8BT Farnborough Hampshire | British | 812680001 | ||||||||||
| LEE, Derek Jonathan | Secretario | Ground Floor Sidda House 350 Lower Addiscombe Road CR0 7AF Croydon C/O Pmms Ltd, United Kingdom | 242541330001 | |||||||||||
| O'SULLIVAN, Liam, Mr. | Secretario | c/o C/O Gh Property Management Services Limited 1 Putney Bridge Approach SW6 3JD London Riverbank House England | 163073640001 | |||||||||||
| ANDERTONS LIMITED | Secretario corporativo | Christopher Wren Yard 117 High Street CR0 1QG Croydon | 99614130001 | |||||||||||
| HES ESTATE MANAGEMENT LIMITED | Secretario corporativo | High Street Bookham KT23 4AA Leatherhead 11/15 Surrey England |
| 255372460001 | ||||||||||
| HINDWOODS LIMITED | Secretario corporativo | Dreadnought Walk SE10 9FP London 9 England |
| 243344550001 | ||||||||||
| HML COMPANY SECRETARIAL SERVICES | Secretario corporativo | 117 High Street CR0 1QG Croydon Christopher Wren Yard Surrey | 130938840001 | |||||||||||
| HML COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | The Quadrant TW9 1BP Richmond 9-11 England United Kingdom |
| 147749880001 | ||||||||||
| J J HOMES PROPERTIES LTD | Secretario corporativo | 31 North Street SM5 2HW Carshalton North House Surrey |
| 157779350001 | ||||||||||
| VFM PROCUREMENT LIMITED | Secretario corporativo | Burrell Row BR3 1AT Beckenham Provident House England |
| 162920150001 | ||||||||||
| AVERY, Helen Katherine | Director | French Apartments Lansdowne CR8 2PJ Purley 43 Surrey | British | 130163880001 | ||||||||||
| BAKER, John | Director | 49 The French Apartments CR8 2PJ Purley Surrey | British | 86444660001 | ||||||||||
| BRAIN, Caroline | Director | Burrell Row BR3 1AT Beckenham Provident House England | United Kingdom | British | 164400020001 | |||||||||
| BRILL, Stephen | Director | Chartland House Old Station Approach KT22 7TE Leatherhead 2 England | England | British | 289079180001 | |||||||||
| BRITTEN, John Russell | Director | French Apartments Lansdowne Road CR8 2PJ Purley 49 Surrey | British | 133290130001 | ||||||||||
| CATLING, Richard Lional | Director | Hollyfox Brunswick Grove KT11 1HP Cobham Surrey | British | 13835700001 | ||||||||||
| CLIFFORD, Paul William | Director | 54 French Apartments Lansdowne Road CR8 2PJ Purley | British | 125720670001 | ||||||||||
| COCKS, Stuart | Director | 47 French Apartments Lansdowne Road CR8 2PJ Purley Surrey | United Kingdom | British | 124821500001 | |||||||||
| CONNOR, John Thomas | Director | 7 West Hill Avenue KT19 8LE Epsom Surrey | British | 25104060001 | ||||||||||
| CONNOR, John Thomas | Director | 7 West Hill Avenue KT19 8LE Epsom Surrey | British | 25104060001 | ||||||||||
| CORRIGAN, Patricia Frances | Director | High Street Bookham KT23 4AA Leatherhead 11-15 Surrey England | United Kingdom | British | 86444590001 | |||||||||
| COUGHLAN, Dominic Matthew | Director | High Street Bookham KT23 4AA Leatherhead 11-15 Surrey England | United Kingdom | Irish | 124760210001 | |||||||||
| HANSON, Chalene Angelique | Director | Chartland House Old Station Approach KT22 7TE Leatherhead 2 England | England | British | 303376180001 | |||||||||
| JESSOP, Simon James | Director | 44 French Apartments Lansdowne Road CR8 2PJ Purley Surrey | British | 70560410001 | ||||||||||
| JESSOP, Simon James | Director | 44 French Apartments Lansdowne Road CR8 2PJ Purley Surrey | British | 70560410001 | ||||||||||
| LAI, Yen Yen | Director | 19 The French Apartments CR8 2PH Purley Surrey | British | 86444550001 | ||||||||||
| MARTIN, David | Director | Chartland House Old Station Approach KT22 7TE Leatherhead 2 England | England | British | 217368380001 | |||||||||
| MEHTA, Rakesh | Director | The French Apartments Lansdowne Road CR8 2PH Purley 3 Surrey | British | 129850390001 | ||||||||||
| MILLS, Billy Alfred | Director | Lansdowne Road CR8 2PH Purley 31 The French Apartments Surrey England | England | British | 88678100001 | |||||||||
| MILLS, Billy Alfred | Director | 31 French Apartments Lansdowne Road CR8 2PH Purley Surrey | England | British | 88678100001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para THE FRENCH APARTMENTS RESIDENTS' ASSOCIATION LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 25 ene 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0