ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED

ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02686643
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED?

    • (7011) /

    ¿Dónde se encuentra ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Ernst & Young Llp No 1
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JOHN LABATT RETAIL LIMITED27 jul 199427 jul 1994
    MAPLE LEAF INNS LIMITED15 may 199215 may 1992
    DECKCLEAR LIMITED12 feb 199212 feb 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2007

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 jun 2010

    5 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 16 abr 2010

    5 páginas4.68

    legacy

    1 páginas287

    Resolución de insolvencia

    Resolution INSOLVENCY:remuneration, books and records
    1 páginasLIQ MISC RES

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 17 abr 2009

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2007

    7 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2006

    7 páginasAA

    legacy

    6 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    6 páginas363a

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2005

    8 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    resolution

    Acuerdo electivo

    ELRES

    Resoluciones

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    resolution

    Acuerdo electivo

    ELRES

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    resolution

    Acuerdo electivo

    ELRES

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2004

    10 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GEORGE, David Colbron
    Harlestone House
    Church Lane
    NN7 4EN Lower Harlestone
    Northamptonshire
    Secretario
    Harlestone House
    Church Lane
    NN7 4EN Lower Harlestone
    Northamptonshire
    British69592110002
    GEORGE, David Colbron
    Harlestone House
    Church Lane
    NN7 4EN Lower Harlestone
    Northamptonshire
    Director
    Harlestone House
    Church Lane
    NN7 4EN Lower Harlestone
    Northamptonshire
    EnglandBritish69592110002
    POOLE, James Andrew
    Vale Cottage
    Oakridge Lynch
    GL6 7NR Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Vale Cottage
    Oakridge Lynch
    GL6 7NR Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish 57614880004
    TUPPEN, Graham Edward
    5 Queensdale Place
    Holland Park
    W11 4SQ London
    Director
    5 Queensdale Place
    Holland Park
    W11 4SQ London
    United KingdomBritish9549960009
    CROSS, Anthony
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    British1812400001
    RUIJS, Mary Johanna
    13 Botfield Avenue
    M9B 4C6 Etobicoke
    Ontario
    Canada
    Secretario
    13 Botfield Avenue
    M9B 4C6 Etobicoke
    Ontario
    Canada
    British42305520001
    RUSNELL, Joanne Doreen
    51 Old Mill Drive
    M6S 4JD Toronto
    Ontario
    Canada
    Secretario
    51 Old Mill Drive
    M6S 4JD Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian9656720002
    THYS, Joseph Marie Victor Patrice
    Rue Yernawe 12
    Saint Georges Sur Meuse 4470
    FOREIGN Belgium
    Secretario
    Rue Yernawe 12
    Saint Georges Sur Meuse 4470
    FOREIGN Belgium
    Belgian45152470001
    ABOGADO CUSTODIANS LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Secretario designado corporativo
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021140001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Secretario designado corporativo
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Secretario designado corporativo
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Secretario designado corporativo
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003220001
    BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    Director
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    United KingdomBritish53682420001
    CRITCHLOW, Christopher Hugh
    45 Solent Road
    West Hampstead
    NW6 1TY London
    Director
    45 Solent Road
    West Hampstead
    NW6 1TY London
    British32989090001
    DIAKIW, Richard John
    Crawfordsburn
    St Georges Road
    KT13 0EP Weybridge
    Surrey
    Director
    Crawfordsburn
    St Georges Road
    KT13 0EP Weybridge
    Surrey
    Canadian39830640001
    ECKMIRE, John
    White Spinney
    10 Broomfield Ride
    KT22 0LW Oxshott
    Surrey
    Director
    White Spinney
    10 Broomfield Ride
    KT22 0LW Oxshott
    Surrey
    Canadian34831670001
    HARRISON, Gordon William
    Bramley House
    Chapel Lane
    S18 4AZ Apperknowle
    Dronfield
    Director
    Bramley House
    Chapel Lane
    S18 4AZ Apperknowle
    Dronfield
    British96987760001
    IZZA, Michael Donald Mccartney
    Sanza 2 Claremont Avenue
    KT10 9JD Esher
    Surrey
    Director
    Sanza 2 Claremont Avenue
    KT10 9JD Esher
    Surrey
    British27447890001
    JACOBS, Marc Philomena Francois
    St Maartenstraat 43/22
    3000 Leuven
    Belgium
    Director
    St Maartenstraat 43/22
    3000 Leuven
    Belgium
    Luxembourger46037650001
    MURRAY, John Duncan
    High Jenks 74a Southampton Road
    SO41 9GZ Lymington
    Hampshire
    Director
    High Jenks 74a Southampton Road
    SO41 9GZ Lymington
    Hampshire
    British52310900002
    PEER, Bruce Edward
    60 Hillholm Road
    M5P 1MS Toronto
    Ontario
    Canada
    Director
    60 Hillholm Road
    M5P 1MS Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian12682100002
    PITT, Christopher James
    Wilton Cottage
    Wildhern
    SP11 0JE Andover
    Hants
    Director
    Wilton Cottage
    Wildhern
    SP11 0JE Andover
    Hants
    United KingdomBritish32115900001
    SANDS, John Robert
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    Director
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    United KingdomBritish141561650001
    WILLIAMS, Sean
    191 Southwood Road
    Rusthall
    TN4 8UX Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    191 Southwood Road
    Rusthall
    TN4 8UX Tunbridge Wells
    Kent
    British40164940001
    ABOGADO CUSTODIANS LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Director designado corporativo
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021140001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Director designado corporativo
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Director designado corporativo
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    ¿Tiene ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security deed
    Creado el 24 may 2002
    Entregado el 05 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The security deed charges in favour of the security trustee by way of a first floating charge all the company's undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag London (The "Security Trustee")on Behalf of Itself and the Banks and Financialinstitutions from Time to Time Party to the Secured Documents
    Transacciones
    • 05 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 27 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security deed
    Creado el 07 jun 2000
    Entregado el 23 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to (the "finance documents") (as defined) and (a credit agreement) (as defined) up to £350,000,000 dated 15 may 2000
    Breve descripción
    The security deed charges in favour of the security trustee by way of a first floating charge all the company's undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag Londonon Behalf of Itself and the Banks and Financialinstitutions from Time to Time Party to the Finance Documents
    Transacciones
    • 23 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 05 jun 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 13 mar 1998
    Entregado el 23 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owned jointly or severaly or in any other capacity whatsoever) of each obligor to any finance party under the finance documents
    Breve descripción
    All the shares and related rights fixed charge all shares and related rights floating charge all its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Investment Bank PLC("Trustee")
    Transacciones
    • 23 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 22 jun 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture created by the company (formerly known as john labatt retail limited)
    Creado el 07 jun 1996
    Entregado el 19 jun 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the finance documents
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Investment Bank PLC(As Trustee for the Finance Parties)
    Transacciones
    • 19 jun 1996Registro de un cargo (395)
    • 15 ago 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assignment
    Creado el 07 ago 1992
    Entregado el 14 ago 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the fourth schedule of a management agreement dated 7/8/92
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all the companys right title and interest and benefit in an interest bearing deposit account k/a the maple leaf inns limited management fees account with no: 97510173 with national westminster bank PLC and all moneys from time to time standing in the nominated including all interest thereon and all amounts deriving therefrom whether directly or indirectly.
    Personas con derecho
    • Brother of Pubmaster Limited
    Transacciones
    • 14 ago 1992Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ENTERPRISE INNS (NO 2) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    17 sept 2010Fecha de disolución
    17 abr 2009Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Ian Best
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Profesional
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Tomislav Lukic
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Profesional
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0