BEST PEOPLE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBEST PEOPLE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02688408
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BEST PEOPLE LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra BEST PEOPLE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hazlitt House
    4 Bouverie Street
    EC4Y 8AX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BEST PEOPLE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RESOURCES INTERNATIONAL PLC07 jul 199207 jul 1992
    STRONGTERM PUBLIC LIMITED COMPANY18 feb 199218 feb 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BEST PEOPLE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BEST PEOPLE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 feb 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 feb 2011

    Estado de capital el 28 feb 2011

    • Capital: GBP 1.002875
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Neil Martin el 01 dic 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Peter William Searle el 01 dic 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Timothy Briant el 01 dic 2010

    1 páginasCH03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Adecco House 71 Elstree Way Borehamwood Hertfordshire WD6 1WD England

    1 páginasAD02

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Amount credited to profit and loss 08/02/2011
    RES13

    Estado de capital el 10 feb 2011

    • Capital: GBP 10,028,745
    4 páginasSH19

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 07 ene 2011

    • Capital: GBP 10,028,745
    4 páginasSH01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Neil Martin el 18 feb 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Timothy Briant el 18 feb 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Peter William Searle el 18 feb 2010

    2 páginasCH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    4 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de BEST PEOPLE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRIANT, Timothy
    Hazlitt House
    4 Bouverie Street
    EC4Y 8AX London
    Secretario
    Hazlitt House
    4 Bouverie Street
    EC4Y 8AX London
    British130048920001
    MARTIN, Neil Thomas George
    Hazlitt House
    4 Bouverie Street
    EC4Y 8AX London
    Director
    Hazlitt House
    4 Bouverie Street
    EC4Y 8AX London
    EnglandBritishDirector126681070003
    SEARLE, Peter William
    Hazlitt House
    4 Bouverie Street
    EC4Y 8AX London
    Director
    Hazlitt House
    4 Bouverie Street
    EC4Y 8AX London
    EnglandBritishDirector116102520004
    ANDREWS, David Thomas
    Lindum High Street
    Lower Dean
    PE28 0LL Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secretario
    Lindum High Street
    Lower Dean
    PE28 0LL Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishCertified Accountant75224270001
    DAVIS, Brian Stuart
    16 Saint Brannocks Road
    M21 0UP Manchester
    Lancashire
    Secretario
    16 Saint Brannocks Road
    M21 0UP Manchester
    Lancashire
    BritishCompany Secretary90639860001
    SADIQ, Christopher John
    80 Disraeli Road
    SW15 2DX London
    Secretario
    80 Disraeli Road
    SW15 2DX London
    British62677440002
    TAGG, Gavin Kenneth
    Flat 16, Cheylesmore House
    Ebury Bridge Road
    SW1W 8QY London
    Secretario
    Flat 16, Cheylesmore House
    Ebury Bridge Road
    SW1W 8QY London
    British95825170001
    TAGG, Gavin Kenneth
    Flat 16, Cheylesmore House
    Ebury Bridge Road
    SW1W 8QY London
    Secretario
    Flat 16, Cheylesmore House
    Ebury Bridge Road
    SW1W 8QY London
    British95825170001
    TODD, Dale
    39 Hare Lane
    Claygate
    KT10 9BT Esher
    Surrey
    Secretario
    39 Hare Lane
    Claygate
    KT10 9BT Esher
    Surrey
    BritishAccountant67865530001
    WICKHAM, Andrew John
    The Acorns
    Workhouse Lane
    ME15 0QB East Farleigh
    Kent
    Secretario
    The Acorns
    Workhouse Lane
    ME15 0QB East Farleigh
    Kent
    BritishChartered Accountant76574430001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDREWS, David Thomas
    Lindum High Street
    Lower Dean
    PE28 0LL Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    Lindum High Street
    Lower Dean
    PE28 0LL Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCertified Accountant75224270001
    BAMFORD, Andrew James
    Byways
    Gravel Walk
    GL53 3NP Cheltenham
    West Midlands
    Gloucestershire
    Director
    Byways
    Gravel Walk
    GL53 3NP Cheltenham
    West Midlands
    Gloucestershire
    BritishIt Recruitment57385050001
    BARFIELD, Richard Timothy
    Wymondham House
    18 Brooklands Avenue
    CB2 2BB Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    Wymondham House
    18 Brooklands Avenue
    CB2 2BB Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector123477010001
    BENNETT, Michael John
    2 Dighton Road
    SW18 1AN London
    Director
    2 Dighton Road
    SW18 1AN London
    BritishDirector74320100001
    BERGIN, Warwick Michael
    409 Nelson House Dolphin Square
    SW1V 3LX London
    Director
    409 Nelson House Dolphin Square
    SW1V 3LX London
    EnglandAustralianCompany Director55073150001
    BRAMLEY-BRETT, Benedict Peter
    Kielder
    7 Onslow Road Burwood Park
    KT12 5BB Walton On Thames
    Surrey
    Director
    Kielder
    7 Onslow Road Burwood Park
    KT12 5BB Walton On Thames
    Surrey
    BritishDirector78406760002
    BUTTERFIELD, Jonathan Russell
    Rock House
    Rockhill, Halberton
    EX16 7AL Tiverton
    Devon
    Director
    Rock House
    Rockhill, Halberton
    EX16 7AL Tiverton
    Devon
    EnglandBritishDirector43387510002
    CANNON, George Anthony
    Princhetts
    Chelsworth
    IP7 7HU Ipswich
    Suffolk
    Director
    Princhetts
    Chelsworth
    IP7 7HU Ipswich
    Suffolk
    BritishCompany Director43000910001
    CUFF, Susan Elizabeth
    154 Hurlingham Road
    SW6 3NG London
    Director
    154 Hurlingham Road
    SW6 3NG London
    BritishManaging Director16966730003
    DARRAUGH, Peter Anthony
    77 Grove Road
    HP23 5PB Tring
    Hertfordshire
    Director
    77 Grove Road
    HP23 5PB Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant82678530001
    FAZAKERLEY, Nicholas
    Adam Cottage Cheverells Green
    Markyate
    AL3 8AD St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Adam Cottage Cheverells Green
    Markyate
    AL3 8AD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector2963820001
    GILES, Andrew Henry
    64 Abbey Road
    CR2 8NG South Croydon
    Surrey
    Director
    64 Abbey Road
    CR2 8NG South Croydon
    Surrey
    BritishDirector64763400001
    GRUBBS, William Joseph
    Flat 2, 3 Chichester Terrace
    BN2 1FG Brighton
    East Sussex
    Director
    Flat 2, 3 Chichester Terrace
    BN2 1FG Brighton
    East Sussex
    AmericanDirector90639790003
    LORD, Andrew
    14 Campbell Close
    Walshaw
    BL8 3BB Bury
    Lancashire
    Director
    14 Campbell Close
    Walshaw
    BL8 3BB Bury
    Lancashire
    BritishRegional Director80091090001
    O'SULLIVAN, John Eugene
    Bonners Farm Windmill Road
    Pepperstock
    LU1 4LQ Luton
    Director
    Bonners Farm Windmill Road
    Pepperstock
    LU1 4LQ Luton
    EnglandBritishDirector141643240001
    STAUNTON, Patricia Mary
    133 Beauchamps Drive
    SS11 8NH Wickford
    Essex
    Director
    133 Beauchamps Drive
    SS11 8NH Wickford
    Essex
    BritishDirector26241680001
    TODD, Dale
    39 Hare Lane
    Claygate
    KT10 9BT Esher
    Surrey
    Director
    39 Hare Lane
    Claygate
    KT10 9BT Esher
    Surrey
    BritishDirector67865530001
    VOICE, David
    25 Mallard Walk
    Mickleover
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    Director
    25 Mallard Walk
    Mickleover
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    BritishDirector82954300001
    WALSH, Catherine
    2b Olivers Wharf
    64 Wapping High Street
    E1W 2PJ London
    Director
    2b Olivers Wharf
    64 Wapping High Street
    E1W 2PJ London
    EnglandBritishCompany Director96023760001
    WICKHAM, Andrew John
    The Acorns
    Workhouse Lane
    ME15 0QB East Farleigh
    Kent
    Director
    The Acorns
    Workhouse Lane
    ME15 0QB East Farleigh
    Kent
    BritishChartered Accountant76574430001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene BEST PEOPLE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    All assets debenture
    Creado el 21 dic 1999
    Entregado el 10 ene 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the financing agrement or on any other account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ene 2000Registro de un cargo (395)
    • 27 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creado el 29 abr 1998
    Entregado el 08 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred by any group company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Intermediate Capital Group PLC (As Security Trustee for the Security Beneficiaries as Defined in the Deed)(the Security Trustee)
    Transacciones
    • 08 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 27 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 06 may 1997
    Entregado el 12 may 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 may 1997Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 13 may 1992
    Entregado el 23 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge on the goodwill bookdebts and patents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 23 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 11 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Book debts debenture
    Creado el 10 may 1992
    Entregado el 19 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Fixed charge on all the beook and other debts see form 395 ref. M125C for full details.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 19 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 26 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0