HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED

HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02689482
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Ldh House St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Cambridgeshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RELAXION SPLASH LIMITED20 feb 199220 feb 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 20 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 feb 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2016

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 feb 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 10 may 2016

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2015

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 mar 2016

    Estado de capital el 15 mar 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2014

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 feb 2015

    Estado de capital el 24 feb 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Leisure Connection Limited Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA a Ldh House St Ives Business Park Parsons Green St. Ives Cambridgeshire PE27 4AA el 22 oct 2014

    1 páginasAD01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 19 sept 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Nombramiento de Mr Ian Arthur Hendrie como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Richard Still como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Richard Still como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HENDRIE, Ian Arthur
    St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Ldh House
    Cambridgeshire
    England
    Secretario
    St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Ldh House
    Cambridgeshire
    England
    187265810001
    HENDRIE, Ian Arthur
    St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Ldh House
    Cambridgeshire
    England
    Director
    St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Ldh House
    Cambridgeshire
    England
    United KingdomBritish123762920001
    NICHOLLS, Julian Frederick
    St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Ldh House
    Cambridgeshire
    England
    Director
    St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Ldh House
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritish95086050001
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    RING, Robert William
    The Common
    Kinsbourne Green
    AL5 3NT Harpenden
    Pinewood
    Herts
    Secretario
    The Common
    Kinsbourne Green
    AL5 3NT Harpenden
    Pinewood
    Herts
    British29354920001
    STILL, Richard Matthew
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    British71581460002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CAMPBELL, Paul Adam
    4 Estelle Road
    Hampstead
    NW3 2JY London
    Director
    4 Estelle Road
    Hampstead
    NW3 2JY London
    British53606250001
    DANIELS, Colin
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    British1278190001
    GOLDING, Nigel William George
    3 Lynwood Green
    SS6 7NE Rayleigh
    Essex
    Director
    3 Lynwood Green
    SS6 7NE Rayleigh
    Essex
    British12415930002
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    MCGINLEY, John Francis
    The Hedges
    Delmerend Lane
    AL3 8ER Flamstead
    Hertfordshire
    Director
    The Hedges
    Delmerend Lane
    AL3 8ER Flamstead
    Hertfordshire
    British8525250001
    MEEHAN, Paul Alan
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish130608590001
    MELLOR, David Glynn
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    Director
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    EnglandBritish57198790001
    RING, Robert William
    The Common
    Kinsbourne Green
    AL5 3NT Harpenden
    Pinewood
    Herts
    Director
    The Common
    Kinsbourne Green
    AL5 3NT Harpenden
    Pinewood
    Herts
    EnglandBritish29354920001
    SMITH, Russell Stansfield
    Woodcliffe Underwood Drive
    Rawdon
    LS19 6LA Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Woodcliffe Underwood Drive
    Rawdon
    LS19 6LA Leeds
    West Yorkshire
    British809230001
    STILL, Richard Matthew
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    Director
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    United KingdomBritish71581460002
    STILL, Richard Matthew
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    Director
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish71581460002
    DANOPTRA DIRECTOR I LIMITED
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Yorkshire
    Director corporativo
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Yorkshire
    125899680001
    DANOPTRA DIRECTOR II LIMITED
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Low Lane
    Yorkshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Low Lane
    Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro02689482
    125899730001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    20 feb 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 16 abr 1997
    Entregado el 22 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 08 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 14 mar 1996
    Entregado el 26 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 08 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 05 abr 1994
    Entregado el 12 abr 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 abr 1994Registro de un cargo (395)
    • 08 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 12 may 1993
    Entregado el 19 may 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 may 1993Registro de un cargo (395)
    • 08 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 01 ago 1992
    Entregado el 20 ago 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a contract bond for £23,385 to south norfolk district council dated 1ST august 1992
    Breve descripción
    The sum of £23,385 together with interest accrued now or to be held by the chargee on an account numbered 45124787 and earmarked by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 20 ago 1992Registro de un cargo (395)
    • 16 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balance
    Creado el 02 abr 1992
    Entregado el 08 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to performance bond dated 28/2/92 in favour of council of the district of east northamptonshire. The sum of £54,000 only
    Breve descripción
    The sum of £54,000 together with interest accrued now or to be held by the chargee on an account numbered 7697988 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 16 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 27 feb 1992
    Entregado el 09 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to performance bond dated 29/02/92 in favour of council of the district of east northamptonshire in respect of contract for the management of rushden and thrapston swimming pools
    Breve descripción
    The sum of £54,000 together with interest accrued now or to be held by the chargee on an account numbered 7697988 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 16 abr 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0