EBBGATE NURSING HOMES LIMITED

EBBGATE NURSING HOMES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEBBGATE NURSING HOMES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02690211
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Angel Court
    EC2R 7HJ London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BASISFOCUS LIMITED24 feb 199224 feb 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 07 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 07 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 07 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    5 páginasAA

    Nombramiento de Mr Michael Harrison como director el 27 abr 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jonathan Stephen Picken como director el 27 abr 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 07 feb 2018 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Bupa Secretaries Limited el 08 dic 2017

    1 páginasCH02

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 1 Angel Court London EC2R 7HJ

    1 páginasAD04

    Modification des détails de Bupa Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 dic 2017

    2 páginasPSC05

    Cambio de datos del secretario Bupa Secretaries Limited el 08 dic 2017

    1 páginasCH04

    Cambio de datos del director Mr Jonathan Stephen Picken el 08 dic 2017

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Bridge House, Outwood Lane Horsforth Leeds LS18 4UP a 1 Angel Court London EC2R 7HJ el 08 dic 2017

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    10 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Bupa House 15-19 Bloomsbury Way London WC1A 2BA

    1 páginasAD03

    Declaración de confirmación presentada el 07 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 feb 2016

    Estado de capital el 29 feb 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    4 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    107319700001
    HARRISON, Michael
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish241166230001
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Director corporativo
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro3155937
    162768400001
    KING, Robert Frederick
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    Secretario
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    British10012650001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Secretario corporativo
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    34893920001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Director
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    CANNON, Andrew John
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Director
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    EnglandBritish200461360001
    DALY, Geoffrey William Stuart
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    Director
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    United KingdomBritish19464860003
    DALY, Geoffrey William Stuart
    97 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LX London
    Director
    97 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LX London
    British19464860001
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DHANDSA, Narinder, Dr
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    Director
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    EnglandBritish115844000001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Director
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270003
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    KING, Robert Frederick
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    Director
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    British10012650001
    LOS, Steven Michael
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Director
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish116895800001
    MERCHANT, Mahboob Ali
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    Director
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish56732410001
    MOORE, Keith
    Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    United Kingdom
    Director
    Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritish49217290002
    PICKEN, Jonathan Stephen
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish189611450001
    REITER, Simon Philip
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    Director
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    United KingdomBritish135845570001
    ROBINSON, Anthony Leake
    17 Chad Road
    Edgbaston
    B15 3ER Birmingham
    West Midlands
    Director
    17 Chad Road
    Edgbaston
    B15 3ER Birmingham
    West Midlands
    British48323880001
    SALISBURY, Nicholas William
    14 Charmouth Road
    AL1 4SW St Albans
    Hertfordshire
    Director
    14 Charmouth Road
    AL1 4SW St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish4380320002
    SINCLAIR BROWN, Frederick John
    Rudge House
    Itchel Lane Crondall
    GU10 5PR Farnham
    Surrey
    Director
    Rudge House
    Itchel Lane Crondall
    GU10 5PR Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish8070730003
    STOREY, Roger Christopher
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    Director
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish1663050001
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Director
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritish62846800003
    THOMAS, Oliver Henry Dixon
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Director
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish256549290001
    TINDALL, Terence William
    19 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    Director
    19 Oak Tree Close
    GU25 4JF Virginia Water
    Surrey
    EnglandBritish4380330001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Director
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro902253
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene EBBGATE NURSING HOMES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 09 ene 2004
    Entregado el 14 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 14 ene 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 ago 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 mar 2001
    Entregado el 11 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations due or to become due from the company to the chargee as trustee for the secured parties (as defined) (the "security trustee") or any of the other secured parties (as defined) including any liability in respect of any further advances made under the facilities or the mezzanine loan facility (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second debenture
    Creado el 27 oct 1998
    Entregado el 02 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All liabilities of any nature of ebbgate nursing homes (london) limited to the chargee and/or any receiver howsoever arising whether under or in connection with the indemnity or otherwise
    Breve descripción
    Legal mortgage - f/h property k/a chestnut court nursing home newton street bury greater manchester-GM509158 and all and whole that plot of ground in the city of edinburgh and county of midlothian (for further details see form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 nov 1998Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security
    Creado el 03 sept 1993
    Entregado el 16 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The whole of the plot of ground in the city of edingburgh and the county of mithlothian extending 4 acres on the soputh of liberton drive in the city of edingburgh and all fixtures and fittings and plant machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 ago 1993
    Entregado el 20 ago 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 ago 1993Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 12 ago 1993
    Entregado el 17 ago 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposits held by the bank on account nos 40115894 and 22202960. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 ago 1993Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 may 1992
    Entregado el 05 jun 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 11/03/92,this debenture,and/or any other security documents
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery see form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays De Zoete Wedd Limited
    Transacciones
    • 05 jun 1992Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0