EBBGATE NURSING HOMES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EBBGATE NURSING HOMES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02690211 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Angel Court EC2R 7HJ London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BASISFOCUS LIMITED | 24 feb 1992 | 24 feb 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Harrison como director el 27 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Stephen Picken como director el 27 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 feb 2018 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Bupa Secretaries Limited el 08 dic 2017 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 1 Angel Court London EC2R 7HJ | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Modification des détails de Bupa Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 dic 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Bupa Secretaries Limited el 08 dic 2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Jonathan Stephen Picken el 08 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Bridge House, Outwood Lane Horsforth Leeds LS18 4UP a 1 Angel Court London EC2R 7HJ el 08 dic 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Bupa House 15-19 Bloomsbury Way London WC1A 2BA | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 07 feb 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 feb 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | 107319700001 | |||||||||||
| HARRISON, Michael | Director | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 241166230001 | |||||||||
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Director corporativo | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom |
| 162768400001 | ||||||||||
| KING, Robert Frederick | Secretario | 8 Prior Bolton Street Canonbury N1 2NX London | British | 10012650001 | ||||||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Secretario corporativo | 42-46 High Street KT10 9QY Esher Surrey | 34893920001 | |||||||||||
| BEAZLEY, Nicholas Tetley | Director | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 105797560001 | |||||||||
| CANNON, Andrew John | Director | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | England | British | 200461360001 | |||||||||
| DALY, Geoffrey William Stuart | Director | Sixpenny Buckle Coldhouse Hill GU22 0QS Woking Surrey | United Kingdom | British | 19464860003 | |||||||||
| DALY, Geoffrey William Stuart | Director | 97 Valiant House Vicarage Crescent SW11 3LX London | British | 19464860001 | ||||||||||
| DAVIES, Julian Peter | Director | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 29367700001 | |||||||||
| DHANDSA, Narinder, Dr | Director | D102 Montevetro 100 Battersea Church Road Battersea SW11 3YL London | England | British | 115844000001 | |||||||||
| ELLERBY, Mark | Director | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | 40582650004 | |||||||||
| GREGORY, Fraser David | Director | 9 Nightingale Shott TW20 9SU Egham Berkshire | United Kingdom | British | 107664270003 | |||||||||
| KENT, Benjamin David Jemphrey | Director | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 93897360003 | |||||||||
| KING, Robert Frederick | Director | 8 Prior Bolton Street Canonbury N1 2NX London | British | 10012650001 | ||||||||||
| LOS, Steven Michael | Director | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 116895800001 | |||||||||
| MERCHANT, Mahboob Ali | Director | 28 Denham Road KT17 3AA Epsom Surrey | United Kingdom | British | 56732410001 | |||||||||
| MOORE, Keith | Director | Outwood Lane Horsforth LS18 4UP Leeds Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 49217290002 | |||||||||
| PICKEN, Jonathan Stephen | Director | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 189611450001 | |||||||||
| REITER, Simon Philip | Director | Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House 15-19 England | United Kingdom | British | 135845570001 | |||||||||
| ROBINSON, Anthony Leake | Director | 17 Chad Road Edgbaston B15 3ER Birmingham West Midlands | British | 48323880001 | ||||||||||
| SALISBURY, Nicholas William | Director | 14 Charmouth Road AL1 4SW St Albans Hertfordshire | England | British | 4380320002 | |||||||||
| SINCLAIR BROWN, Frederick John | Director | Rudge House Itchel Lane Crondall GU10 5PR Farnham Surrey | United Kingdom | British | 8070730003 | |||||||||
| STOREY, Roger Christopher | Director | 11 Newlands SG6 2JE Letchworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 1663050001 | |||||||||
| TAYLOR, Neil Robert | Director | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | 62846800003 | |||||||||
| THOMAS, Oliver Henry Dixon | Director | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 256549290001 | |||||||||
| TINDALL, Terence William | Director | 19 Oak Tree Close GU25 4JF Virginia Water Surrey | England | British | 4380330001 | |||||||||
| WALFORD, Arthur David | Director | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 6658190001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bupa Investments Limited | 06 abr 2016 | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene EBBGATE NURSING HOMES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 09 ene 2004 Entregado el 14 ene 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 28 mar 2001 Entregado el 11 abr 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All obligations due or to become due from the company to the chargee as trustee for the secured parties (as defined) (the "security trustee") or any of the other secured parties (as defined) including any liability in respect of any further advances made under the facilities or the mezzanine loan facility (as defined) on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Second debenture | Creado el 27 oct 1998 Entregado el 02 nov 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All liabilities of any nature of ebbgate nursing homes (london) limited to the chargee and/or any receiver howsoever arising whether under or in connection with the indemnity or otherwise | |
Breve descripción Legal mortgage - f/h property k/a chestnut court nursing home newton street bury greater manchester-GM509158 and all and whole that plot of ground in the city of edinburgh and county of midlothian (for further details see form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 03 sept 1993 Entregado el 16 sept 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The whole of the plot of ground in the city of edingburgh and the county of mithlothian extending 4 acres on the soputh of liberton drive in the city of edingburgh and all fixtures and fittings and plant machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 12 ago 1993 Entregado el 20 ago 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over credit balances | Creado el 12 ago 1993 Entregado el 17 ago 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The deposits held by the bank on account nos 40115894 and 22202960. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 28 may 1992 Entregado el 05 jun 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 11/03/92,this debenture,and/or any other security documents | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery see form 395 for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0