RICHMOND SUPPORT SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RICHMOND SUPPORT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02691646 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RICHMOND SUPPORT SERVICES LIMITED?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra RICHMOND SUPPORT SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 15 Wheatstone Court, Davy Way Waterwells Business Park, GL2 2AQ Quedgeley, Gloucester |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RICHMOND SUPPORT SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| WORKWORLD LIMITED | 03 mar 2004 | 03 mar 2004 |
| J T APPOINTMENTS LIMITED | 06 jul 1999 | 06 jul 1999 |
| JUST TEMPS LTD. | 27 feb 1992 | 27 feb 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RICHMOND SUPPORT SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para RICHMOND SUPPORT SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RICHMOND SUPPORT SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2024 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Anthony Plinston como secretario el 01 oct 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Zoe Gibbs como secretario el 01 oct 2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2024 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2023 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Alison Vaughan como director el 01 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed workworld LIMITED\certificate issued on 17/10/23 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2022 | 17 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 38 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 026916460007 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 026916460006 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 sept 2021 | 17 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 36 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr John Anthony Plinston el 18 feb 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RICHMOND SUPPORT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBBS, Zoe | Secretario | 15 Wheatstone Court, Davy Way Waterwells Business Park, GL2 2AQ Quedgeley, Gloucester | 328129960001 | |||||||
| LAWRENCE, Paul Andrew | Director | 15 Wheatstone Court, Davy Way Waterwells Business Park, GL2 2AQ Quedgeley, Gloucester | England | British | 69811790003 | |||||
| PLINSTON, John Anthony | Director | 15 Wheatstone Court, Davy Way Waterwells Business Park, GL2 2AQ Quedgeley, Gloucester | England | British | 9872770016 | |||||
| VAUGHAN, Alison | Director | 15 Wheatstone Court, Davy Way Waterwells Business Park, GL2 2AQ Quedgeley, Gloucester | Wales | Welsh | 322978110001 | |||||
| BARTON, Beverley Ann Howden | Secretario | 17 Canon Woods Way Kennington TN24 9QY Ashford Kent | British | 20211900002 | ||||||
| LAWRENCE, Paul Andrew | Secretario | 3 The Retreat Bell Pitch Whiteshill GL6 6BS Stroud Gloucestershire | British | 69811790001 | ||||||
| MESSENGER, Maureen Elizabeth | Secretario | 129 Beaver Lane TN23 5NX Ashford Kent | British | 19932690001 | ||||||
| PLINSTON, John Anthony | Secretario | 15 Wheatstone Court, Davy Way Waterwells Business Park, GL2 2AQ Quedgeley, Gloucester | British | 9872770003 | ||||||
| CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED | Secretario designado corporativo | Temple House 20 Holywell Row EC2A 4JB London | 900000860001 | |||||||
| BARTON, Peter Henry | Director | Old Orchard House Sandyhurst Lane TN25 4PF Ashford Kent | British | 54202750001 | ||||||
| BENN, Jonathan David | Director | Grange Road Clifton BS8 4EA Bristol 22 England | United Kingdom | British | 36657530005 | |||||
| BIRD, Wayne Anthony | Director | 209 Mendip Road Yatton BS49 4ED Bristol | British | 59761550001 | ||||||
| CARROUCHE, Nicola Jane | Director | 14 Cawston Lane CV22 6QE Dunchurch Warwickshire | United Kingdom | British | 106533000001 | |||||
| CLOUGH, Mark Simon | Director | 2 Whitegate Park Flixton M41 6LW Manchester | British | 56462390002 | ||||||
| GUNN-FORBES, Alastair | Director | Beverley Close SW13 0EH London 10 United Kingdom | England | British | 26965220005 | |||||
| GUNN-FORBES, Alastair | Director | 96 Christchurch Road East Sheen SW14 7AX London | United Kingdom | British | 26965220001 | |||||
| HAZZARD, Lawrence Gordon | Director | 5 Balfour Place W1K 2AU London | England | British | 21898740001 | |||||
| HAZZARD, Lawrence Gordon | Director | 5 Balfour Place W1K 2AU London | England | British | 21898740001 | |||||
| HEADECH, Michael | Director | 129 Beaver Lane TN23 5NX Ashford Kent | British | 19932710001 | ||||||
| KAY, Philip Bruce, Dr | Director | 187 Camberwell Grove SE5 8JU London | England | British | 46741280002 | |||||
| MCDONNELL, Steven | Director | 33 Broadfield Gardens Great Meadow WR4 0DP Worcester Worcestershire | Welsh | 63918730001 | ||||||
| MESSENGER, Maureen Elizabeth | Director | 129 Beaver Lane TN23 5NX Ashford Kent | British | 19932690001 | ||||||
| PENNIE, Christopher | Director | 2 Jubilee Cottages Manston Road Manston CT12 5AY Ramsgate Kent | British | 59761210001 | ||||||
| TUGGEY, Stephen John | Director | 42 Serpentine Road Harborne B17 9RE Birmingham West Midlands | British | 18098620001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RICHMOND SUPPORT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opera Holdings Limited | 06 abr 2016 | Wheatstone Court Waterwells Business Park GL2 2AQ Quedgeley Gloucester 15 Gloucestershire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0