UNICORN ABRASIVES LIMITED

UNICORN ABRASIVES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaUNICORN ABRASIVES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02692560
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de UNICORN ABRASIVES LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra UNICORN ABRASIVES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UNICORN ABRASIVES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ACROSSFREE LIMITED02 mar 199202 mar 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de UNICORN ABRASIVES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para UNICORN ABRASIVES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    4 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Doxey Road Stafford ST1B 1EA el 11 oct 2010

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 sept 2010

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Nombramiento de Mr Philip Edward Moore como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Thierry Lambert como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    8 páginasAA

    Cambio de datos del director Thierry Lambert el 24 jun 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Alun Roy Oxenham el 28 abr 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Alun Roy Oxenham el 28 abr 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 01 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 mar 2010

    Estado de capital el 23 mar 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    15 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    ¿Quiénes son los directivos de UNICORN ABRASIVES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OXENHAM, Alun Roy
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    Secretario
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    British72478560002
    MOORE, Philip Edward
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    Director
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector60599570002
    OXENHAM, Alun Roy
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    Director
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Saint-Gobain House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary72478560002
    COLE, Ian Robert
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    Secretario
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    British42980510001
    GARDNER, Norman Arthur
    The Glen
    Gorsley
    HR9 7SG Ross On Wye
    Herefordshire
    Secretario
    The Glen
    Gorsley
    HR9 7SG Ross On Wye
    Herefordshire
    BritishCompany Director624700001
    GAUT, Stephen Harvey
    J Tixall Mews
    Tixall
    ST18 0XT Stafford
    Staffordshire
    Secretario
    J Tixall Mews
    Tixall
    ST18 0XT Stafford
    Staffordshire
    British1612220001
    LEES, Dennis
    29 The Crescent
    ST21 6AZ Eccleshall
    Staffordshire
    Secretario
    29 The Crescent
    ST21 6AZ Eccleshall
    Staffordshire
    BritishAccountant101846960001
    LLOYD, Melvryn
    24 Ludgate Avenue
    DY11 6JP Kidderminster
    Worcestershire
    Secretario
    24 Ludgate Avenue
    DY11 6JP Kidderminster
    Worcestershire
    British1463180001
    MILLS, Michael John
    Maple Heath
    Parsonage Lane Farnham Common
    SL2 3NZ Slough
    Berkshire
    Secretario
    Maple Heath
    Parsonage Lane Farnham Common
    SL2 3NZ Slough
    Berkshire
    BritishDirector34628600001
    WILLIAMS, Simon James
    10 Poplar Grove
    W6 7RE London
    Secretario
    10 Poplar Grove
    W6 7RE London
    British26816470001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BUFFAT, Bernard
    21 Rue Reaumur
    FOREIGN Paris
    75003
    France
    Director
    21 Rue Reaumur
    FOREIGN Paris
    75003
    France
    FrenchDirector63509620001
    BUYS, William Frederick
    Brawns
    Bix
    RG9 4RY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Brawns
    Bix
    RG9 4RY Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishDirector97730001
    CARPENTIER, Benoit
    38 Avenue De La Faisanderie
    1150 Woluwe Saint-Pierre
    Belgium
    Director
    38 Avenue De La Faisanderie
    1150 Woluwe Saint-Pierre
    Belgium
    FrenchCompany Director66138190001
    COHEN, Ronald Mourad, Sir
    3 Stanley Crescent
    W11 2NB London
    Director
    3 Stanley Crescent
    W11 2NB London
    EnglandBritishDirector35541250002
    COLE, Ian Robert
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    Director
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    BritishAccountant42980510001
    DE CHALENDAR, Pierre Andre
    15 Avenue Robert-Schumann
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    Director
    15 Avenue Robert-Schumann
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    FrenchDirector63509130002
    FISHER, Ian
    145 King Henrys Road
    NW3 3RD London
    Director
    145 King Henrys Road
    NW3 3RD London
    United KingdomIsraeliDirector51776160003
    FLETCHER, Alan Thomas
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    Director
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    BritishDirector14669590001
    GARDNER, Norman Arthur
    The Glen
    Gorsley
    HR9 7SG Ross On Wye
    Herefordshire
    Director
    The Glen
    Gorsley
    HR9 7SG Ross On Wye
    Herefordshire
    BritishCompany Director624700001
    GAUT, Stephen Harvey
    J Tixall Mews
    Tixall
    ST18 0XT Stafford
    Staffordshire
    Director
    J Tixall Mews
    Tixall
    ST18 0XT Stafford
    Staffordshire
    BritishDirector1612220001
    GAUT, Stephen Harvey
    J Tixall Mews
    Tixall
    ST18 0XT Stafford
    Staffordshire
    Director
    J Tixall Mews
    Tixall
    ST18 0XT Stafford
    Staffordshire
    BritishAccountant1612220001
    GIBB, Ewan Kenneth
    4 Mill Lane
    Bentley Heath
    B93 8PB Solihull
    West Midlands
    Director
    4 Mill Lane
    Bentley Heath
    B93 8PB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishFinance Director80661050001
    HALL, Richard William John
    2 Tooke Road
    GL6 9DA Minchinhampton
    Gloucestershire
    Director
    2 Tooke Road
    GL6 9DA Minchinhampton
    Gloucestershire
    BritishCompany Director34219520001
    LAMBERT, Thierry
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Merchant House
    United Kingdom
    Director
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Merchant House
    United Kingdom
    FrenchDeputy General Delegate136578380002
    LAZARD, Roland, Mr.
    Aldwych House
    81 Aldwych
    WC2B 4HQ London
    Director
    Aldwych House
    81 Aldwych
    WC2B 4HQ London
    FrenchGeneral Delegate Uk Ireland An105253300003
    LEVIN, David Saul
    9 Cardigan Mansions
    Richmond Hill
    TW10 6RD Richmond
    Surrey
    England
    Director
    9 Cardigan Mansions
    Richmond Hill
    TW10 6RD Richmond
    Surrey
    England
    BritishCompany Director33968040001
    LLOYD, Melvryn
    24 Ludgate Avenue
    DY11 6JP Kidderminster
    Worcestershire
    Director
    24 Ludgate Avenue
    DY11 6JP Kidderminster
    Worcestershire
    BritishChartered Accountant1463180001
    MILLS, Michael John
    Maple Heath
    Parsonage Lane Farnham Common
    SL2 3NZ Slough
    Berkshire
    Director
    Maple Heath
    Parsonage Lane Farnham Common
    SL2 3NZ Slough
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector34628600001
    NEETESON, Reinier Paul
    Avenue General Baron Empain 3
    1150 Brussels
    Belgium
    Director
    Avenue General Baron Empain 3
    1150 Brussels
    Belgium
    DutchDirector52393790001
    RIMMER, David Norman
    20 Badgers Croft
    Eccleshall
    ST21 6DS Stafford
    Staffordshire
    Director
    20 Badgers Croft
    Eccleshall
    ST21 6DS Stafford
    Staffordshire
    BritishCompany Director71617270001
    SAYERS, Nicholas Davip
    23 Langland Gardens
    NW3 6QE London
    Director
    23 Langland Gardens
    NW3 6QE London
    BritishSolicitor69917330002
    WARD, Charles William Nelson
    Rowan House
    Beech Grange Hopwas
    B78 3AS Tamworth
    Staffs
    Director
    Rowan House
    Beech Grange Hopwas
    B78 3AS Tamworth
    Staffs
    BritishCompany Director30227970001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene UNICORN ABRASIVES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 ago 1994
    Entregado el 15 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the "finance documents" (as defined in the deed)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co. Limitedthe "Security Agent"
    Transacciones
    • 15 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge of shares
    Creado el 18 jun 1992
    Entregado el 29 jun 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents(as defined)
    Breve descripción
    All dividends and proceeds from time to time receivable in relation to 100 ordinary shares of italian lire 5,ooo nominal value each in the share capital of L.M.van moppes & sons S.P.A.(see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co.Limited (The Security Agent)
    Transacciones
    • 29 jun 1992Registro de un cargo (395)
    • 14 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge of shares
    Creado el 20 mar 1992
    Entregado el 10 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company and each other "obligor" (as defined) to morgan grenfell & co. Limited ("the security agent") and the "lenders" (as defined) (or any of them) under the terms of any of the "finance documents" (as defined)
    Breve descripción
    All dividends paid or payable on 50 shares with a nominal value of DF1.1000 Per share in the share capital of english abrasives holland B.V.(see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co.Limited
    Transacciones
    • 10 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 14 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Memorandum of deposit of shares
    Creado el 20 mar 1992
    Entregado el 08 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each other "obligor" (as defined) to morgan grenfell & co. Limited ("the security agent") and the "lenders" (as defined) (or any of them) under the terms of any of the "finance documents" (as defined)
    Breve descripción
    All dividends and sums paid or payable on 4,000 shares of £1 each held in its (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co.Limited
    Transacciones
    • 08 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 14 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creado el 20 mar 1992
    Entregado el 07 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each other "obligor" (as defined) to morgan grenfell & co. Limited ("the security agent") and the "lenders" (as defined) (or any of them) under the terms of any of the "finance documents" (as defined)
    Breve descripción
    All dividends paid or payable ON7,500 ordinary shares of sek 100 each in industridiamanter ab.(see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co.Limited
    Transacciones
    • 07 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 14 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge of shares
    Creado el 20 mar 1992
    Entregado el 07 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each other "obligor" (as defined) to morgan grenfell & co. Limited ("the security agent") and the "lenders" (as defined) (or any of them) under the terms of any of the "finance documents" (as defined)
    Breve descripción
    All dividends paid or payable on 100 shares of common stock in unicorn industries inc.(see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co.Limited
    Transacciones
    • 07 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 14 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge of shares
    Creado el 20 mar 1992
    Entregado el 07 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each other "obligor" (as defined) to morgan grenfell & co. Limited ("the security agent") and the "lenders" (as defined) (or any of them) under the terms of any of the "finance documents" (as defined)
    Breve descripción
    All dividends paid or payable on 100,000 shares of Y500 each in nippon van moppes limited (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co.Limited
    Transacciones
    • 07 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 14 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creado el 20 mar 1992
    Entregado el 07 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each other "obligor" (as defined) to morgan grenfell & co. Limited ("the security agent") and the "lenders" (as defined) (or any of them) under the terms of any of the "finance documents" (as defined)
    Breve descripción
    All dividends paid or payable on 8,095 shares of bef 1,000 each in lm van moppes & sons nv (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co.Limited
    Transacciones
    • 07 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 14 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creado el 20 mar 1992
    Entregado el 07 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company and each other "obligor" (as defined) to morgan grenfell & co. Limited ("the security agent") and the "lenders" (as defined) (or any of them) under the terms of any of the "finance documents" (as defined)
    Breve descripción
    All dividends paid or payable ON749 shares of bef 4,000 each in nv belgian tool company sa (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co.Limited
    Transacciones
    • 07 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 14 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creado el 20 mar 1992
    Entregado el 07 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company and each other "obligor" (as defined) to morgan grenfell & co. Limited ("the security agent") and the "lenders" (as defined) (or any of them) under the terms of any of the "finance documents" (as defined)
    Breve descripción
    All dividends paid or payable on 1,500 shares of sfr.100 Each in lm van moppes & sons sa,certificate nos.1 To 6 constituting the entire capital stock of the company (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co.Limited
    Transacciones
    • 07 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 14 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 20 mar 1992
    Entregado el 03 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from thecompany and/or all or any of the obligors (as defined) to the chargee and each of the lenders under the terms of any of the finance documents (as defined)
    Breve descripción
    See form 395 ref M80 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co.Limitedthe Security Agent
    Transacciones
    • 03 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene UNICORN ABRASIVES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 sept 2010Inicio de la liquidación
    19 ago 2011Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Nigel Heath Sinclair
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharine'S Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharine'S Way
    E1W 1DD London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0