HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED

HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHIGHWAY (BURNLEY) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02693859
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    • (8514) /

    ¿Dónde se encuentra HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Craegmoor House
    Perdiswell Park
    WR3 7NW Worcestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BRIAN CHRISTOPHER PROPERTY LIMITED16 abr 199216 abr 1992
    BANDNAME LIMITED05 mar 199205 mar 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de David Manson como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David James Hall como secretario

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Philip Henry Scott como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Jason David Lock como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Matthew Franzidis como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Scott Morrison como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Albert Smith como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christine Cameron como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Julian Ball como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 05 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 mar 2011

    Estado de capital el 30 mar 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    legacy

    2 páginas288a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    16 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas353a

    legacy

    1 páginas190a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HALL, David James
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    159660530001
    FRANZIDIS, Matthew
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandUk129251300001
    LOCK, Jason David
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish144822040001
    SCOTT, Philip Henry
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish174231320001
    CHRISTOPHER, Brian John
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Secretario
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British18037120001
    CHRISTOPHER, Richard Robert Edward
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    Secretario
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    British54424700002
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Secretario
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    BLG (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    Secretario corporativo
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    39680630001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDREWS, Carole
    155 Watermoor Road
    GL7 1LF Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    155 Watermoor Road
    GL7 1LF Cirencester
    Gloucestershire
    British102238960001
    BALL, Julian Charles
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    Director
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    EnglandBritish138044110001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    Director
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish113187140001
    CAMERON, Christine Isabel
    10 Mount Crescent
    HR1 NQ1 Hereford
    Director
    10 Mount Crescent
    HR1 NQ1 Hereford
    EnglandBritish163745150001
    CAVANAGH, Peter Kenneth
    8 Fir Grove
    Paddington
    WA1 3JF Warrington
    Director
    8 Fir Grove
    Paddington
    WA1 3JF Warrington
    British114627410002
    CHRISTOPHER, Barbara Ruth
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Director
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British18037140001
    CHRISTOPHER, Brian John
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Director
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British18037120001
    CHRISTOPHER, Richard Robert Edward
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    Director
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    British54424700002
    HILL, Margaret
    11 Pear Tree Close
    Hollingsworth
    S43 2LU Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    11 Pear Tree Close
    Hollingsworth
    S43 2LU Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish102587360001
    KAY, Allyson
    12 Folks Wood Way
    Stone Street Lympne
    CT21 4EW Hythe
    Kent
    Director
    12 Folks Wood Way
    Stone Street Lympne
    CT21 4EW Hythe
    Kent
    British93464240001
    KEATING, Denise Elizabeth
    62 Church Street
    Cogenhoe
    NN7 1LS Northampton
    Northamptonshire
    Director
    62 Church Street
    Cogenhoe
    NN7 1LS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish111513540001
    MANSON, David Lindsay
    111 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    Director
    111 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish126071210001
    NEWHAM, Pamela Maria
    Rowan Cottage
    38 Reedley Road Reedley
    BB10 2LU Burnley
    Lancashire
    Director
    Rowan Cottage
    38 Reedley Road Reedley
    BB10 2LU Burnley
    Lancashire
    British69690300002
    SAVILLE, Richard Cyril Campbell
    Fairings
    Valley Way
    SL9 7PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Fairings
    Valley Way
    SL9 7PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish38530070001
    SMITH, Albert Edward
    Flint House
    Froxfield
    SN8 3JY Marlborough
    Wiltshire
    Director
    Flint House
    Froxfield
    SN8 3JY Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritish77631340001
    SPURLING, Julian Neville Guy
    Foundry House
    GU35 9LY Kingsley
    Hampshire
    Director
    Foundry House
    GU35 9LY Kingsley
    Hampshire
    EnglandBritish110225070001
    STRATFORD, Michael Anthony
    10 Anne Hathaway Drive
    GL3 2PX Churchdown
    Gloucestershire
    Director
    10 Anne Hathaway Drive
    GL3 2PX Churchdown
    Gloucestershire
    United KingdomBritish38853720002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of accession and charge acceeding to the debenture dated 18 july 2008 and
    Creado el 02 oct 2008
    Entregado el 08 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The acquisition agreement claims all rights in respect of the insurance policies, the hedging agreements, any structural intra group loans fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 08 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 17 sept 2007
    Entregado el 26 sept 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 26 sept 2007Registro de un cargo (395)
    • 23 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental legal mortgage
    Creado el 11 mar 2006
    Entregado el 21 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    3 talbot street burnley t/n LA486809,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental legal mortgage
    Creado el 11 mar 2006
    Entregado el 21 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The property being 3 talbot street burnley t/n LA486809,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Lenders)
    Transacciones
    • 21 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite debenture
    Creado el 11 mar 2006
    Entregado el 21 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (Security Agent)
    Transacciones
    • 21 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite debenture
    Creado el 31 dic 2004
    Entregado el 06 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from craegmoor homes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 oct 2003
    Entregado el 06 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 oct 2003
    Entregado el 06 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 oct 2003
    Entregado el 06 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from craegmoor homes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 15 feb 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 26 feb 1999
    Entregado el 05 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 nov 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 mar 1993
    Entregado el 13 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a 30 talbot street burnley inc: fixtuer and fittings title no: LA485170. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank PLC
    Transacciones
    • 13 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 28 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0