VECTOR INVESTMENTS LIMITED

VECTOR INVESTMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVECTOR INVESTMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02693876
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    • Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O INTERPATH LTD
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BEFOREKEEP LIMITED05 mar 199205 mar 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    17 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 12 dic 2023

    17 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 12 dic 2022

    18 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Destitución del liquidador por orden judicial

    104 páginasLIQ10

    Domicilio social registrado cambiado de 10 Fleet Place London EC4M 7QS a 10 Fleet Place London EC4M 7RB el 01 jul 2022

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 16 Palace Street London England SW1E 5JQ a 10 Fleet Place London EC4M 7QS el 04 ene 2022

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 13 dic 2021

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 26 sept 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    9 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 26 sept 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2018

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 26 sept 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 26 sept 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2017

    18 páginasAA

    Nombramiento de Khwaja Kamran Shah como director el 09 abr 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Rashidi Olugbenga Keshiro como director el 09 abr 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 19 sept 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2016

    22 páginasAA

    Cese del nombramiento de Guat Hoon (Known as Christina) Ong como director el 06 oct 2016

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MUHAMMAD, Junaid Muhammad Rahimullah
    Level 15,
    Sheikh Zayed Road
    P.O. BOX 17000 Dubai
    Conrad Building
    United Arab Emirates
    Director
    Level 15,
    Sheikh Zayed Road
    P.O. BOX 17000 Dubai
    Conrad Building
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesPakistani214227180001
    SHAH, Khwaja Kamran
    0000 Discovery Gardens
    Apt 204 Building 107
    United Arab Emirates
    Director
    0000 Discovery Gardens
    Apt 204 Building 107
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesPakistani245280080001
    COOMBE, Cynthia Mary
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    Secretario
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    155194520001
    HOWARD, Albert Larry
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    Secretario
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    British73770040001
    HUDSON, Alan Edmund Wilchen
    79 Porchfield Square
    St John's Gardens
    M3 4FG Manchester
    Secretario
    79 Porchfield Square
    St John's Gardens
    M3 4FG Manchester
    British38798810002
    JONES, Roger Kenneth
    41 Townscliffe Lane
    Marple Bridge
    SK6 5AP Stockport
    Cheshire
    Secretario
    41 Townscliffe Lane
    Marple Bridge
    SK6 5AP Stockport
    Cheshire
    British11127840001
    MCCAUSLAND, Siobhan Mary
    64 Shawdene Road
    M22 4AL Manchester
    Lancashire
    Secretario
    64 Shawdene Road
    M22 4AL Manchester
    Lancashire
    British2583820001
    MOORE, Michael Anthony
    17 Pine Road
    Didsbury
    M20 6UY Manchester
    Lancashire
    Secretario
    17 Pine Road
    Didsbury
    M20 6UY Manchester
    Lancashire
    British4609510001
    PARKINSON, Evelyn
    53 Tyrer Road
    WA12 8SP Newton Le Willows
    Merseyside
    Secretario
    53 Tyrer Road
    WA12 8SP Newton Le Willows
    Merseyside
    British9842960001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALUISI, Patricia Ann
    76 Cadogan Place
    SW1X 9RP London
    Director
    76 Cadogan Place
    SW1X 9RP London
    American23362430001
    BARNETT, Ian Gregory Howie
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    Director
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    United KingdomBritish11591280001
    BATE, Dennis
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    Director
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    British28569910001
    BEVERTON, John Davey
    29 Eaton Square
    SW1 9DF London
    Director
    29 Eaton Square
    SW1 9DF London
    British7646360002
    BROOKS, Gary
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    Director
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    United KingdomBritish108919970001
    CHARLTON, Richard Wingate Edward
    8 Fernshaw Road
    SW10 0TF London
    Director
    8 Fernshaw Road
    SW10 0TF London
    United KingdomBritish15470710001
    CORSER, Raymond Bidlake
    Robinswood 1 Dashwood Close
    West Byfleet
    KT14 6QH Wey Bridge
    Surrey
    Director
    Robinswood 1 Dashwood Close
    West Byfleet
    KT14 6QH Wey Bridge
    Surrey
    British55914130002
    FLETCHER, Angus Howard
    Lees Heights
    OX7 3EZ Charlbury
    9
    United Kingdom
    Director
    Lees Heights
    OX7 3EZ Charlbury
    9
    United Kingdom
    United KingdomBritish65254010001
    HOWARD, Albert Larry
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    Director
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritish73770040001
    JOHNSON, David Arthur
    133 Newtown Road
    BH31 6EH Verwood
    Dorset
    Director
    133 Newtown Road
    BH31 6EH Verwood
    Dorset
    British10394350002
    KESHIRO, Rashidi Olugbenga
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    Director
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    United KingdomBritish120935530001
    LEESE, Richard Charles, Sir
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    Director
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    United KingdomBritish53459790002
    LEESE, Richard Charles, Sir
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    Director
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    United KingdomBritish53459790002
    MACKIE, Colin Dwight
    Highcourt
    11 Tadcaster Road
    YO23 3UL Copmanthorpe
    North Yorkshire
    Director
    Highcourt
    11 Tadcaster Road
    YO23 3UL Copmanthorpe
    North Yorkshire
    United KingdomBritish78640920001
    MOORE, Michael Anthony
    17 Pine Road
    Didsbury
    M20 6UY Manchester
    Lancashire
    Director
    17 Pine Road
    Didsbury
    M20 6UY Manchester
    Lancashire
    British4609510001
    ONG, Guat Hoon (Known As Christina)
    The Galleries Building 4, Level 6
    Downtown Jebel Ali, PO BOX 17000
    Dubai
    Istithmar World Pjsc
    United Arab Emirates
    Director
    The Galleries Building 4, Level 6
    Downtown Jebel Ali, PO BOX 17000
    Dubai
    Istithmar World Pjsc
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesSingaporean197371130001
    REAMES, Rodney Charles Dudley
    83 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Director
    83 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British33215200001
    THOMAS OF MACCLESFIELD, Terence James, Lord
    51 Willowmead Drive
    SK10 4DD Prestbury
    Cheshire
    Director
    51 Willowmead Drive
    SK10 4DD Prestbury
    Cheshire
    British85130800001
    TRIPPIER, David Austin, Sir
    Dowry Head
    Helmshore
    BB4 4AE Rossendale
    Lancashire
    Director
    Dowry Head
    Helmshore
    BB4 4AE Rossendale
    Lancashire
    British27871400001
    TURNER, Norman Patrick
    Hillside Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    Director
    Hillside Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    British9842980001
    WADDINGTON, Robert
    83 Bourne Street
    SW1W 8HQ London
    Director
    83 Bourne Street
    SW1W 8HQ London
    British72682390002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro6067171
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene VECTOR INVESTMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Third security assignment
    Creado el 30 may 2003
    Entregado el 05 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in to and arising under the relevant agreements and the relevant insurances and any moneys payable or to the account of the assignor thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capital Bank Corporate Finance PLC
    Transacciones
    • 05 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security assignment
    Creado el 02 oct 2000
    Entregado el 05 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the amended lease agreements or any of the other financing documents (as defined)
    Breve descripción
    All the company's right title benefit and interest in and to the assigned rights where the assigned rights are all the right title benefit and interest of the chargor in to or arising out of or in connection with clause 5 of the release and guarantee agreement dated 2ND october 2000. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capital Bank Corporate Finance PLC
    Transacciones
    • 05 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security assignment
    Creado el 26 sept 1997
    Entregado el 01 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the lessors, under or pursuant to any of the lease agreements or any of the other financing documents (as defined in the deed)
    Breve descripción
    All of the assignor's right title benefit and interest to and in the assigned rights and all the benefits of all policies, contracts and agreements in respect of the relevant insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capital Bank Corporate Finance PLC
    Transacciones
    • 01 oct 1997Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security assignment
    Creado el 29 dic 1995
    Entregado el 10 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the lease agreements or any of the other financing documents
    Breve descripción
    All of the assignor's right title benefit and interst to and in the assigned rights, the charged account, the deposit and all the benefits of all policies, contracts and agreements in respect of the relevant insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nws Corporate Finance PLC as Agent and Security Trustee for Itself and the Lessors
    Transacciones
    • 10 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 dic 1995
    Entregado el 10 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any lease agreements or any of the other financing documents
    Breve descripción
    L/H-the international olympic arena, manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nws Corporate Finance PLC as Agent and Security Trustee for Itself and the Lessors
    Transacciones
    • 10 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security account charge
    Creado el 29 dic 1995
    Entregado el 09 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any of the lease agreements or any of the other financing documents
    Breve descripción
    All of the company's right title benefit and interest to and in the deposit of £2,000,000 deposited in the account numbered 70329986 in the company's name held with co-op bank at its branch at po box 101, 1 balloon street, manchester M60 4EP sort code 08-90-00.
    Personas con derecho
    • Nws Corporate Finance PLC(As Agent and Security Trustee for Itself and the Lessors)
    Transacciones
    • 09 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 13 sept 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignment of building contract
    Creado el 05 nov 1993
    Entregado el 25 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the co-operative bank PLC and agent and trustee for itself, bovis construction limited and/or the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever under the terms of the assignment (as defined therein)
    Breve descripción
    A building contract d/d 24/08/93 to construct an indoor sports arena adjacent to victoria railways station manchester. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC ("the Agent")
    Transacciones
    • 25 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 05 nov 1993
    Entregado el 25 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the co-operative bank PLC as agent and trustee for itself,bovis construction limited and/or the beneficiaries (as defined) or any of them under the terms of the assignment (as defined therein)
    Breve descripción
    All right title and interest of the company under a building agreement and underlease d/d 04/12/92 an agreement d/d 14/04/93 and an agreement d/d 27/05/93. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC ("the Agent")
    Transacciones
    • 25 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 nov 1993
    Entregado el 25 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the co-operative bank PLC as agent and trustee for itself and bovis construction limited and/or the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever under the terms of the debenture (as defined therein)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC ("the Agent")
    Transacciones
    • 25 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 feb 1993
    Entregado el 19 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bovis Construction Limited
    Transacciones
    • 19 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 feb 1993
    Entregado el 15 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 15 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 ene 1993
    Entregado el 11 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 11 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 01 feb 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 10 nov 1992
    Entregado el 27 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & buildings at roger street/brighton street cheetham hill manchester t/no's la 34630 la 52063 la 115564 & la 52062 with buildings & fixtures and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 27 nov 1992Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene VECTOR INVESTMENTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    13 dic 2021Inicio de la liquidación
    25 abr 2024Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Stephen John Absolom
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profesional
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicholas James Timpson
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profesional
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Howard Smith
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profesional
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0