FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY
Visión general
| Nombre de la empresa | FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
| Número de empresa | 02698195 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY?
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY?
| Dirección de la sede social | 5th Floor Leconfield House Curzon Street W1J 5JA London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 may 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 may 2020 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Nicole Ann Martin el 23 abr 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Nicole Ann Martin el 19 sept 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Nicole Ann Martin el 19 sept 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 mar 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Nicole Ann Martin como director el 07 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Klosters Limited como director el 07 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 may 2019 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 may 2018 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy John Smalley como director el 03 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Robert Tchenguiz como director el 03 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 may 2017 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 may 2016 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Renuncia del auditor | 3 páginas | AUD | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 may 2015 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN, Nicole Ann | Director | Floor Leconfield House Curzon Street W1J 5JA London 5th | United Kingdom | British | 244758010003 | |||||||||||||
| TCHENGUIZ, Robert | Director | Floor Leconfield House Curzon Street W1J 5JA London 5th | England | British | 74322720004 | |||||||||||||
| DUNCAN, Rosemary | Secretario | 3066 119th Street Toledo 43611 United States Of America | American | 65379670001 | ||||||||||||||
| INGHAM, Michael Harry Peter | Secretario | 3 Lauriston Road Wimbledon SW19 4TJ London | British | 2739650001 | ||||||||||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||||||||||
| BARNARD, Neal Brian | Director | 26703 Nawash Drive Perrysburg 43551 Ohio United States Of America | American | 67684380001 | ||||||||||||||
| BEHAM, Joseph Alan | Director | 6029 Wild Ivy Court Sylvania Ohio 43560 Usa | American | 56706690001 | ||||||||||||||
| BISHOP, Paul J | Director | 1801 Richards Road Toledo Ohio 43697 Usa | American | 51363820003 | ||||||||||||||
| BISHOP, Paul J | Director | 724 E Boundary Road 43551 Perrysburg Ohio Usa | American | 51363820001 | ||||||||||||||
| DEY, Jayanta | Director | 13759 Heron Circle FOREIGN Clearwater Florida 34622 Usa | American | 21435320001 | ||||||||||||||
| GRUNNELL, Mark | Director | Montolieu Gardens SW15 6PB London 3 | United Kingdom | British | 94144450002 | |||||||||||||
| HOLY, Julian Robert | Director | 33 Spencer Road W4 3SS Chiswick Greater London | United Kingdom | British | 91517950001 | |||||||||||||
| MOYER, Kevin P | Director | 26788 Mohawk Drive 43551 Perrysburg Ohio Usa | American | 51343000001 | ||||||||||||||
| POLLOCK, Robert Evans | Director | 3640 Brookside FOREIGN Toledo Ohio 43606 Usa | American | 21435340001 | ||||||||||||||
| SHULTZ, Edward | Director | 7164 Forest Brook Drive 43560 Sylvania Ohio Usa | American | 45098000001 | ||||||||||||||
| SMALLEY, Timothy John | Director | Chivers Road CM15 0LG Stondon Massey Stondon Place Essex | United Kingdom | British | 102593650002 | |||||||||||||
| TCHENGUIZ, Robert | Director | Royal College Of Organists 26 Kensington Gore SW7 2ET London | England | British | 74322720004 | |||||||||||||
| TCHENGUIZ, Robert | Director | 6 Chesterfield Hill Mayfair W1J 5BL London | Iranian | 74322720002 | ||||||||||||||
| KLOSTERS LIMITED | Director corporativo | Les Banques St Sampsons GY1 3HS Guernsey La Tonnelle House Channel Islands |
| 188565290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatevalley Limited | 06 abr 2016 | Curzon Street W1J 5JA London 5th Floor, Leconfield House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene FARNBOROUGH AIRPORT PROPERTIES COMPANY alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 12 oct 2005 Entregado el 20 oct 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the lender parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción L/H property k/a bristol house t/no HP451127 and york house t/no HP451125 at lakeside road, farnborough, hampshire, all rights, title, interest and benefit in and to the rent account and the rent account deposit and to any account proceeds and floating charge its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 09 mar 2004 Entregado el 17 mar 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the lender parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The l/h property k/a bristol house t/n HP451127 and york house t/n HP451125 at lakeside road farnborough hampshire, all of its rights title and interest and benefit in and to the rent account and the rent account deposit, in and to the free cash account and the free cash account deposit. By way of second floating charge its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 21 ago 1992 Entregado el 26 ago 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the trust indenture and other security documents (as defined | |
Breve descripción L/H buildings S2 & S3 farnborough aerospace centre farnborough hants.floating charge over see form 395 for details. Undertaking and all property and assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Memorandum of charge over rent account | Creado el 21 ago 1992 Entregado el 26 ago 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indenture trust and other security documents (as defined | |
Breve descripción All rights title interest in and to all amounts standing to the credit of the company on account no.3056279 With citibank N.A. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0