HOODEN HORSE INNS LIMITED

HOODEN HORSE INNS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHOODEN HORSE INNS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02700525
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HOODEN HORSE INNS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra HOODEN HORSE INNS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HOODEN HORSE INNS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOODEN HORSE INNS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de David Forde como director el 31 jul 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 17 ene 2020

    • Capital: GBP 2.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    2 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    legacy

    79 páginasPARENT_ACC

    Nombramiento de Mr Sean Michael Paterson como director el 24 abr 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David James Tannahill como director el 24 abr 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable en cours prolongé du 24 ago 2018 au 31 dic 2018

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 04 abr 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 19 ago 2017

    3 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF a Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE el 08 sept 2017

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Punch Taverns (Ib) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept 2017

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Francesca Appleby como secretario el 29 ago 2017

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Stephen Peter Dando como director el 29 ago 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Edward Michael Bashforth como director el 29 ago 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Forde como director el 29 ago 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Christopher John Moore como director el 29 ago 2017

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de HOODEN HORSE INNS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MOORE, Christopher John
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Director
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish136853310001
    MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Director
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish112375050001
    PATERSON, Sean Michael
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    Director
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    ScotlandBritish257892140001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191627820001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    BROWN, Robert Adam Southall
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    Secretario
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    British67809020001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Secretario designado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    HARRINGTON, Columb
    4 Drovers Way
    Newton Longville
    MK17 0HR Buckinghamshire
    Secretario
    4 Drovers Way
    Newton Longville
    MK17 0HR Buckinghamshire
    Irish51845740002
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175488160001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    SAVAGE, Neil Howard
    Belmont Farm
    Snoad Hill, Bethersden
    TN26 3DY Ashford
    Kent
    Secretario
    Belmont Farm
    Snoad Hill, Bethersden
    TN26 3DY Ashford
    Kent
    British64244340001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161624270001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    BENSLEY, Alex Vincent
    Crabb Cottage Lenham Heath Road
    Lenham
    ME17 2BU Maidstone
    Kent
    Director
    Crabb Cottage Lenham Heath Road
    Lenham
    ME17 2BU Maidstone
    Kent
    British26841140002
    BROWN, Robert Adam Southall
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    Director
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    British67809020001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    ELLIOTT, Roy Lewis
    Chilmington Cottage Chilmington Green
    Great Chart
    TN23 3DP Ashford
    Kent
    Director
    Chilmington Cottage Chilmington Green
    Great Chart
    TN23 3DP Ashford
    Kent
    British13331850001
    FORDE, David
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Director
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomIrish180590780001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Director designado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    JACKSON, Alan Marchant
    Woodrow Farm
    Wigginton
    HP23 6HT Tring
    Hertfordshire
    Director
    Woodrow Farm
    Wigginton
    HP23 6HT Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritish18341590001
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    Director
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritish79388130005
    LAMBERT, Stephen David
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    Director
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    British43572470001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Director
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    SAVAGE, Neil Howard
    Belmont Farm
    Snoad Hill, Bethersden
    TN26 3DY Ashford
    Kent
    Director
    Belmont Farm
    Snoad Hill, Bethersden
    TN26 3DY Ashford
    Kent
    British64244340001
    TANNAHILL, David James
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Director
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    ScotlandBritish237381690001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HOODEN HORSE INNS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    29 ago 2017
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    No
    Forma jurídicaCorporate
    País de registroScotland
    Autoridad legalUnited Kingdom (Scotland)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc065527
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    06 abr 2016
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1899248
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene HOODEN HORSE INNS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 14 sept 1999
    Entregado el 05 oct 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors each of them to the secured creditors (or any of them) under the facility documents (or any of them) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited (As Trustee for the Secured Creditors)
    Transacciones
    • 05 oct 1999Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 21 feb 1994
    Entregado el 23 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The hooden horse inn maytham road rolvenden kent t/n K342057 together with the goodwill of the business carried on therefrom.
    Personas con derecho
    • First National Bank PLC
    Transacciones
    • 23 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 06 jun 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Loan agreement and legal charge
    Creado el 03 dic 1993
    Entregado el 07 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £170,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed
    Breve descripción
    The f/h properties "the rose inn" public house willesborough kent t/n k 414790 and "the hooden horse" public house the street greater chart ashford kent t/n k 298812.
    Personas con derecho
    • Greene King PLC
    Transacciones
    • 07 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 06 jun 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Loan agreement and legal charge
    Creado el 17 jun 1993
    Entregado el 23 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £110,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    F/H the rose inn public house willesborough kent t/n K414790.
    Personas con derecho
    • Greene King PLC
    Transacciones
    • 23 jun 1993Registro de un cargo (395)
    • 17 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 30 nov 1992
    Entregado el 04 dic 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The duke of york public house high street cranbrook kent t/n k 341843 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 dic 1992Registro de un cargo (395)
    • 06 jun 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0