HOODEN HORSE INNS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HOODEN HORSE INNS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02700525 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HOODEN HORSE INNS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra HOODEN HORSE INNS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HOODEN HORSE INNS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOODEN HORSE INNS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Forde como director el 31 jul 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 17 ene 2020
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 79 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
Nombramiento de Mr Sean Michael Paterson como director el 24 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David James Tannahill como director el 24 abr 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 24 ago 2018 au 31 dic 2018 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 19 ago 2017 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF a Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE el 08 sept 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Punch Taverns (Ib) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Francesca Appleby como secretario el 29 ago 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Peter Dando como director el 29 ago 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Edward Michael Bashforth como director el 29 ago 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Forde como director el 29 ago 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher John Moore como director el 29 ago 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HOODEN HORSE INNS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE, Christopher John | Director | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 136853310001 | |||||
| MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge | Director | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 112375050001 | |||||
| PATERSON, Sean Michael | Director | South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Broadway Park Scotland | Scotland | British | 257892140001 | |||||
| APPLEBY, Francesca | Secretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191627820001 | |||||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Secretario | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| BROWN, Robert Adam Southall | Secretario | 24 Alders Brook Hilton DE65 5HF Derby Derbyshire | British | 67809020001 | ||||||
| GRAEME, Dorothy May | Secretario designado | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001330001 | ||||||
| HARRINGTON, Columb | Secretario | 4 Drovers Way Newton Longville MK17 0HR Buckinghamshire | Irish | 51845740002 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Secretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175488160001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| SAVAGE, Neil Howard | Secretario | Belmont Farm Snoad Hill, Bethersden TN26 3DY Ashford Kent | British | 64244340001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
| TYRRELL, Helen | Secretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161624270001 | |||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Director | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| BENSLEY, Alex Vincent | Director | Crabb Cottage Lenham Heath Road Lenham ME17 2BU Maidstone Kent | British | 26841140002 | ||||||
| BROWN, Robert Adam Southall | Director | 24 Alders Brook Hilton DE65 5HF Derby Derbyshire | British | 67809020001 | ||||||
| DANDO, Stephen Peter | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| ELLIOTT, Roy Lewis | Director | Chilmington Cottage Chilmington Green Great Chart TN23 3DP Ashford Kent | British | 13331850001 | ||||||
| FORDE, David | Director | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | 180590780001 | |||||
| GRAEME, Lesley Joyce | Director designado | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001320001 | ||||||
| JACKSON, Alan Marchant | Director | Woodrow Farm Wigginton HP23 6HT Tring Hertfordshire | England | British | 18341590001 | |||||
| KEMP, Deborah Jane | Director | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | 79388130005 | |||||
| LAMBERT, Stephen David | Director | Fernley 84 Newmarket Road NR2 2LB Norwich Norfolk | British | 43572470001 | ||||||
| MCDONALD, Robert James | Director | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| SAVAGE, Neil Howard | Director | Belmont Farm Snoad Hill, Bethersden TN26 3DY Ashford Kent | British | 64244340001 | ||||||
| TANNAHILL, David James | Director | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | Scotland | British | 237381690001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HOODEN HORSE INNS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Uk Limited | 29 ago 2017 | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Punch Taverns (Ib) Limited | 06 abr 2016 | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene HOODEN HORSE INNS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 14 sept 1999 Entregado el 05 oct 1999 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the obligors each of them to the secured creditors (or any of them) under the facility documents (or any of them) on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 21 feb 1994 Entregado el 23 feb 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The hooden horse inn maytham road rolvenden kent t/n K342057 together with the goodwill of the business carried on therefrom. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Loan agreement and legal charge | Creado el 03 dic 1993 Entregado el 07 dic 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £170,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed | |
Breve descripción The f/h properties "the rose inn" public house willesborough kent t/n k 414790 and "the hooden horse" public house the street greater chart ashford kent t/n k 298812. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Loan agreement and legal charge | Creado el 17 jun 1993 Entregado el 23 jun 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £110,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción F/H the rose inn public house willesborough kent t/n K414790. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 30 nov 1992 Entregado el 04 dic 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The duke of york public house high street cranbrook kent t/n k 341843 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0