FACTITO LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | FACTITO LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02700778 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de FACTITO LIMITED?
- Actividades de organizaciones profesionales de miembros (94120) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra FACTITO LIMITED?
| Dirección de la sede social | 9 Appold Street 6th Floor EC2A 2AP London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FACTITO LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PMI SERVICES LIMITED | 01 may 1992 | 01 may 1992 |
| ARMAGRET LIMITED | 26 mar 1992 | 26 mar 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de FACTITO LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para FACTITO LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 05 feb 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 19 feb 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 05 feb 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para FACTITO LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 05 feb 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Girish Menezes como director el 03 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Robert Anthony Wakefield como director el 03 dic 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
Registro de la carga 027007780001, creada el 28 jul 2025 | 16 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 10 páginas | MA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Girish Menezes como director el 04 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed pmi services LIMITED\certificate issued on 16/06/25 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Keith Whalley como director el 04 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Anthony Wakefield como director el 04 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Gareth Tancred como director el 04 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Ruston Smith como director el 04 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Rosemary Anne Lacey como director el 04 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Louise Drummond como director el 04 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Rachika Oshadhi Cooray como director el 04 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Anjan Bose como director el 04 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mrs Francesca Beatrice Garrett-Levy como secretario el 04 jun 2025 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Matthew Knowles como director el 04 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Robert Anthony Wakefield como director el 25 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Raymonde Anthony Nathan como director el 29 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Anthony Wakefield como director el 29 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de FACTITO LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARRETT-LEVY, Francesca Beatrice | Secretario | Appold Street 6th Floor EC2A 2AP London 9 England | 336775430001 | |||||||
| KNOWLES, Matthew | Director | Appold Street 6th Floor EC2A 2AP London 9 England | England | British | 253574730001 | |||||
| WAKEFIELD, Robert Anthony | Director | Appold Street 6th Floor EC2A 2AP London 9 England | England | British | 298698980001 | |||||
| BARBER, Alan Michael | Secretario | 1 Bentley Close CM23 3JZ Bishop's Stortford Hertfordshire | British | 72738580001 | ||||||
| BHARWANI, Waheed | Secretario | 18 St Crispin House 2 Barclay Road CR0 1JN Croydon Surrey | British | 122173800001 | ||||||
| BOLAKY, Pronista | Secretario | 66 Park Hill SM5 3RZ Carshalton Beeches Surrey | British | 112339940001 | ||||||
| BOLAKY, Pronista | Secretario | 66 Park Hill SM5 3RZ Carshalton Beeches Surrey | British | 112339940001 | ||||||
| HOWLETT, Susan Margaret | Secretario | Winchmore Linersh Wood Bramley GU5 0EF Guildford Surrey | British | 16232850001 | ||||||
| CCS SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900001720001 | |||||||
| AITKEN, Ian Montgomery | Director | Marly Hill EH39 4QX North Berwick East Lothian | British | 79642420001 | ||||||
| ALEXANDER, Lesley Jane | Director | Appold Street 6th Floor EC2A 2AP London 9 England | England | British | 189384580002 | |||||
| ALEXANDER, Lesley Jane | Director | 4-10 Artillery Lane London E1 7LS | England | British | 201356700001 | |||||
| ANDREWS, Susan Jane | Director | Crown Place EC2A 4ES London 30 United Kingdom | England | British | 77085490007 | |||||
| APPLEGARTH, Susan | Director | Gold Hill GU10 3JH Lower Bourne Farnham 9 Surrey | United Kingdom | British | 162719330001 | |||||
| ASHMORE, Anthony John | Director | Silwood 7 West End Grove GU9 7EG Farnham Surrey | United Kingdom | British | 207320001 | |||||
| BODIE, Nigel Duncan Vaughan | Director | 3 The Mount Drive RH2 0EZ Reigate Surrey | United Kingdom | British | 169830310001 | |||||
| BOLAKY, Prontista | Director | Park Hill SM5 3RZ Carshalton Beeches 66 Surrey | Uk | British | 150368300001 | |||||
| BOLDING, Neil Andrew | Director | Tolleshunt Darcy Road Tolleshunt Major CM9 8LN Maldon Bonds Essex | British | 106839950001 | ||||||
| BOSE, Anjan | Director | Appold Street 6th Floor EC2A 2AP London 9 England | England | British | 277844130001 | |||||
| BRAITHWAITE, Norman John | Director | Withinlee Court Withinlee Road, Prestbury SK10 4AT Macclesfield Cheshire | British | 66894530001 | ||||||
| BRANAGH, Robert John | Director | Old Broad Street Tower 42 EC2N 1HQ London Floor 20 England | England | British | 146096800001 | |||||
| BRIDGES, Robert Hugh | Director | 17 Clock House Apartments Enton Lane Enton GU8 5AS Godalming Surrey | England | British | 59433870002 | |||||
| BRIGHT, David John | Director | The Ridge House 59 Bluehouse Lane Limpsfield RH8 0AP Oxted Surrey | United Kingdom | British | 97012670001 | |||||
| COBLEY, Roger | Director | 5 Beacon Lane Little Bealings IP13 6LZ Woodbridge Suffolk | England | British | 18692640002 | |||||
| COOK, Sara | Director | Appold Street 6th Floor EC2A 2AP London 9 England | England | British | 123511170001 | |||||
| COORAY, Rachika Oshadhi | Director | Appold Street 6th Floor EC2A 2AP London 9 England | England | British | 228566170001 | |||||
| COUCHMAN, Paul Dennis | Director | 4-10 Artillery Lane London E1 7LS | England | British | 123511120005 | |||||
| CRIGHTON, Neil | Director | 562 Ben Jonson House Barbican EC2Y 8DL London | British | 39723470001 | ||||||
| CRITCHELL, Brian Edward | Director | 18 Millen Court The Street DA4 9GR Horton Kirby Kent | United Kingdom | British | 164589730001 | |||||
| CRITCHELL, Brian Edward | Director | Tregarne 32 Wood Lane Darenth DA2 7LR Dartford Kent | British | 3603050001 | ||||||
| DEGAUTE, Gerard Patrick | Director | Old Broad Street Tower 42 EC2N 1HQ London Floor 20 England | England | British | 16989080001 | |||||
| DEGAUTE, Gerard Patrick | Director | 68 Meadowbank SG4 0HY Hitchin Hertfordshire | England | British | 16989080001 | |||||
| DELO, Stephen John | Director | 14 Heyworth Ride Bolnore Village RH16 4TN Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | 63817330003 | |||||
| DRUMMOND, Sarah Louise | Director | Appold Street 6th Floor EC2A 2AP London 9 England | Scotland | British | 284703210001 | |||||
| EDELIN DE LA PRAUDIERE, Yvonne Desiree | Director | 39 Aylmer Road W12 9LG London | British | 29478600001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para FACTITO LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 26 mar 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0