ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02701726 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
- Comercio al por mayor de otros productos intermedios (46760) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Dirección de la sede social | Unit 14-17 Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Essex |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
HIREUS LIMITED | 30 mar 1992 | 30 mar 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 oct 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 31 jul 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 oct 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 abr 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 14 may 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 abr 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2023 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Judith Alexandra Stone como secretario el 28 abr 2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Lewis Dickinson como secretario el 28 abr 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Notification de Martyn Peter Stone en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 abr 2024 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||
Notification de Judith Alexandra Stone en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 abr 2024 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||
Cessation de Andrew Lewis Dickinson en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 abr 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2022 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2021 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2020 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2019 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2018 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Martyn Peter Stone el 13 may 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2017 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 oct 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 may 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 oct 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew Lewis Dickinson el 10 dic 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STONE, Judith Alexandra | Secretario | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | 322549900001 | |||||||
DICKINSON, Andrew Lewis | Director | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | Wales | British | Salesman | 53581760003 | ||||
STONE, Judith Alexandra | Director | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | Wales | British | Government Agency Policy Maker | 165693160001 | ||||
STONE, Martyn Peter | Director | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | Wales | British | Police Officer | 181036560001 | ||||
DICKINSON, Andrew Lewis | Secretario | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | 187654580001 | |||||||
DICKINSON, Janet Valerie | Secretario | 8 Cheshire Close RM11 3ER Hornchurch Essex | British | 53581560001 | ||||||
GRAEME, Dorothy May | Secretario designado | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001330001 | ||||||
MASCALL, Alan | Secretario | 7 Hawksmoor Green Hutton CM13 1LE Brentwood Essex | British | 32704980001 | ||||||
MERRY, Anthony | Secretario | Ardleigh Acres Harts Lane CO7 7QQ Aedleigh Essex | British | 74403790001 | ||||||
RIGBY, Raymond Victor | Secretario | The Plantations Eaton Grange Long Eaton NG10 3QG Nottingham 8 Nottinghamshire England | 151629690001 | |||||||
TURNER, Carol Anne | Secretario | 29 Brampton Close Corringham SS17 7NS Stanford Le Hope Essex | British | 43945750001 | ||||||
CARTER, Robert John | Director | 76 Bramwoods Road Great Baddow CM2 7LT Chelmsford Essex | British | Warehouse Manager | 32704990002 | |||||
DICKINSON, Andrew Lewis | Director | 9 Cheshire Close RM11 3ER Hornchurch Essex | British | Salesman | 53581760001 | |||||
DICKINSON, Janet Valerie | Director | 8 Cheshire Close RM11 3ER Hornchurch Essex | British | Secretary | 53581560001 | |||||
GRAEME, Lesley Joyce | Director designado | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001320001 | ||||||
MASCALL, Alan | Director | 7 Hawksmoor Green Hutton CM13 1LE Brentwood Essex | British | Sales And Office Manager | 32704980001 | |||||
MERRY, Anthony | Director | Ardleigh Acres Harts Lane CO7 7QQ Aedleigh Essex | United Kingdom | British | Sales Administrator | 74403790001 | ||||
RIGBY, Raymond Victor | Director | 8 The Plantations Eaton Grange Long Eaton NG10 3QG Nottingham | United Kingdom | British | Sales Manager | 34821840001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
---|---|---|---|
Mrs Judith Alexandra Stone | 28 abr 2024 | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Wales | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Martyn Peter Stone | 28 abr 2024 | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Wales | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Andrew Lewis Dickinson | 06 abr 2016 | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Wales | |||
Naturaleza del control
|
¿Tiene ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creado el 22 may 2002 Entregado el 23 may 2002 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 17 barleyfield hinckley leicester / hinckley and bosworth t/no: LT326589. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 10 ago 1999 Entregado el 12 ago 1999 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Frteehold land k/a units 14 and 15 thurrock commercial park juliette way essex purfleet essex t/n EX566470. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 19 ene 1996 Entregado el 24 ene 1996 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fixed equitable charge | Creado el 27 ene 1995 Entregado el 04 feb 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed equitable charge over all book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 26 ago 1993 Entregado el 06 sept 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Unit 17 thurrock commercial park purfleet industrial estate london road purfleet essex.t/no.ex 430649. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 18 ago 1992 Entregado el 26 ago 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Unit 16, thurrock commercial park, purfleet industrial estate, london road, purfleet, essex t/no. EX436904. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 14 ago 1992 Entregado el 24 ago 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción For full details see form 395 tc ref: M301C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0