HTSS REALISATIONS LIMITED

HTSS REALISATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHTSS REALISATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02702383
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HTSS REALISATIONS LIMITED?

    • fabricación de otros productos de metal n.c.o.p. (25990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra HTSS REALISATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    7th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HTSS REALISATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HI-TECH STEEL SERVICES LIMITED21 may 199221 may 1992
    HIGH-TECH STEEL SERVICES LIMITED18 may 199218 may 1992
    SILVER SERIES LIMITED31 mar 199231 mar 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HTSS REALISATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HTSS REALISATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    18 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 abr 2017

    18 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 abr 2016

    10 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 abr 2015

    12 páginas4.68

    Informe de progreso del administrador hasta 10 abr 2014

    17 páginas2.24B

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    1 páginas2.34B

    Resultado de la reunión de acreedores

    54 páginas2.23B

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed hi-tech steel services LIMITED\certificate issued on 18/12/13
    6 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name18 dic 2013

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 25 nov 2013

    RES15

    Resoluciones

    Resolutions
    5 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 25 nov 2013

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Declaración de la propuesta del administrador

    57 páginas2.17B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    32 páginas2.16B

    Domicilio social registrado cambiado de * 1 St Ann Street Manchester M2 7LR* el 18 nov 2013

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de * Bold Industrial Park Neills Road Bold St Helens Merseyside WA9 4TU* el 22 oct 2013

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cancelación total de la carga 1

    4 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 abr 2013

    Estado de capital el 12 abr 2013

    • Capital: GBP 85,000
    SH01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2012

    28 páginasAA

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2011

    29 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 jun 2012 au 31 dic 2011

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 01 jul 2011

    29 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de HTSS REALISATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GORMAN, Ian Christopher
    76 Harboro Road
    M33 6GE Sale
    Cheshire
    Secretario
    76 Harboro Road
    M33 6GE Sale
    Cheshire
    British27325370002
    GARDNER, Christopher Michael
    Merrybent Drive
    Merrybent
    DL2 2JZ Darlington
    17
    County Durham
    United Kingdom
    Director
    Merrybent Drive
    Merrybent
    DL2 2JZ Darlington
    17
    County Durham
    United Kingdom
    EnglandBritish32950590005
    GORMAN, Ian Christopher
    76 Harboro Road
    M33 6GE Sale
    Cheshire
    Director
    76 Harboro Road
    M33 6GE Sale
    Cheshire
    EnglandBritish27325370002
    WELLS, Stephen William
    The Firs
    Frog Lane Milton Green
    CH3 9DN Tattenhall
    Cheshire
    Director
    The Firs
    Frog Lane Milton Green
    CH3 9DN Tattenhall
    Cheshire
    United KingdomBritish4650510001
    WOODWARD, Peter
    10 Arncliffe Grove
    DL3 8UN Darlington
    County Durham
    Director
    10 Arncliffe Grove
    DL3 8UN Darlington
    County Durham
    Great BritainBritish56667770001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secretario designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    MACHIN, Robert William
    64 Elm Drive
    Holmes Chapel
    CW4 7QG Crewe
    Cheshire
    Director
    64 Elm Drive
    Holmes Chapel
    CW4 7QG Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish56667950001
    WILBERFORCE, Barry
    Wood Cottage
    Whitchurch Road
    CW6 9RU Spurstow
    Cheshire
    Director
    Wood Cottage
    Whitchurch Road
    CW6 9RU Spurstow
    Cheshire
    Great BritainBritish27325380002
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    ¿Tiene HTSS REALISATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 20 ago 2010
    Entregado el 24 ago 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Fortis Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 24 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 30 may 2008
    Entregado el 03 jun 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 03 jun 2008Registro de un cargo (395)
    • 06 ago 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 24 may 1996
    Entregado el 05 jun 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Transacciones
    • 05 jun 1996Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 21 oct 1993
    Entregado el 28 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a factoring agreement, leasing agreement or otherwise
    Breve descripción
    The ultimate balance due or owing to the company by tih under any factoring agreement and the ultimate balance due or owing to the company by tih under a factoring agreement dated 6/10/93 and all other book and other debts and claims due or owing to or purchased or acquired by the company and the full benefit of all rights and remedies relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Trade Indemnity-Heller Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 28 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 13 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 may 1992
    Entregado el 27 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene HTSS REALISATIONS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 oct 2013Inicio de la administración
    10 abr 2014Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David Thornhill
    1 St Ann Street
    M2 7LR Manchester
    Profesional
    1 St Ann Street
    M2 7LR Manchester
    Geoffrey Paul Rowley
    1 St Ann Street
    M2 7LR Manchester
    Profesional
    1 St Ann Street
    M2 7LR Manchester
    2
    FechaTipo
    10 abr 2014Inicio de la liquidación
    06 oct 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Geoffrey Paul Rowley
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Liquidador propuesto
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    David Thornhill
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Liquidador propuesto
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Geoffrey Paul Rowley
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Profesional
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    David Thornhill
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Profesional
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0