PEC (LIVERPOOL) LIMITED

PEC (LIVERPOOL) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPEC (LIVERPOOL) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02703966
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PEC (LIVERPOOL) LIMITED?

    • (2224) /

    ¿Dónde se encuentra PEC (LIVERPOOL) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    10 Broad Ground Road
    Lakeside
    B98 8YP Redditch
    Worcestershire
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PEC (LIVERPOOL) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE PALATINE ENGRAVING COMPANY LIMITED18 may 199218 may 1992
    ADAPTPRAISE LIMITED06 abr 199206 abr 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PEC (LIVERPOOL) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PEC (LIVERPOOL) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    5 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 10-11 Broad Ground Road Lakeside Redditch Worcestershire B98 8YP el 09 oct 2009

    1 páginasAD01

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    5 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    14 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    páginas363(288)

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2005

    15 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    2 páginas287

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed the palatine engraving company l imited\certificate issued on 02/02/06
    2 páginasCERTNM

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2004

    18 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2003

    18 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2002

    18 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    2 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de PEC (LIVERPOOL) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    Secretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British43547190002
    BOBST, Jean Pascal
    Ch Des Cornalles 20
    Corseaux
    Vaud 1802
    Director
    Ch Des Cornalles 20
    Corseaux
    Vaud 1802
    Swiss86417270001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    Director
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish43547190002
    CLARKE, John Graham
    The Red Lodge Parkgate Road
    Mollington
    CH1 6NE Chester
    Secretario
    The Red Lodge Parkgate Road
    Mollington
    CH1 6NE Chester
    British42329580001
    HOCKING, John
    12 Blenheim Close
    BB1 8QL Blackburn
    Lancashire
    Secretario
    12 Blenheim Close
    BB1 8QL Blackburn
    Lancashire
    British20383980002
    WILLIAMS, Stephen Robert
    School Lane
    Knowsley Industrial Park South
    L34 9GJ Knowsley
    Merseyside
    Secretario
    School Lane
    Knowsley Industrial Park South
    L34 9GJ Knowsley
    Merseyside
    British31595990001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AUSTIN, Ronald George
    Blythe House
    Sandfield Park
    L12 1NA Liverpool
    Director
    Blythe House
    Sandfield Park
    L12 1NA Liverpool
    British36193370001
    BLAKE, Alan Paul
    27 Grosvenor Road
    Birkdale
    PR8 2ES Southport
    Merseyside
    Director
    27 Grosvenor Road
    Birkdale
    PR8 2ES Southport
    Merseyside
    British14327290001
    BLAKE, Patricia Margaret
    27b Grosvenor Road
    Birkdale
    PR8 2ES Southport
    Lancashire
    Director
    27b Grosvenor Road
    Birkdale
    PR8 2ES Southport
    Lancashire
    British38533590001
    BRADLEY, David
    105 Whalley Road
    Read
    BB12 7RP Burnley
    Lancashire
    Director
    105 Whalley Road
    Read
    BB12 7RP Burnley
    Lancashire
    British27377510001
    DARRICOTTE, Geoffrey Crosland
    Beaufort House
    Edstone Court
    B95 6DD Wooton Wawen
    Warwickshire
    Director
    Beaufort House
    Edstone Court
    B95 6DD Wooton Wawen
    Warwickshire
    British11491410002
    LAING, Stephen George
    27 Ashburton Road
    CH43 8TN Prenton
    Merseyside
    Director
    27 Ashburton Road
    CH43 8TN Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritish24914370001
    OWEN, Michael Barry
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    Director
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    EnglandBritish69716360003
    PARKER, Keith Graham
    73 Westbourne Park
    Urmston
    M41 0XR Manchester
    Greater Manchester
    Director
    73 Westbourne Park
    Urmston
    M41 0XR Manchester
    Greater Manchester
    British43176920001
    RIDINGS, Mark Antony
    30 Bowden Green
    WR9 8WZ Droitwich Spa
    Worcestershire
    Director
    30 Bowden Green
    WR9 8WZ Droitwich Spa
    Worcestershire
    United KingdomBritish110267840001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene PEC (LIVERPOOL) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 28 ago 1996
    Entregado el 07 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings on the westerly side of fox street north west side of bute street and on the easterly side of douro street liverpool with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 07 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 05 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 19 dic 1995
    Entregado el 28 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and premises at fox street liverpool MS274849 and MS129706. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 28 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 22 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 nov 1992
    Entregado el 11 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Floating charge the whole of the company's undertaking property and assets including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Ethel Austin Properties Holdings Limited
    Transacciones
    • 11 nov 1992Registro de un cargo (395)
    • 22 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 nov 1992
    Entregado el 11 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Floating charge the whole of the company's undertaking peoperty and assets including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • M.B.Owen,P.W.Bullivant and S.P.Prescott
    Transacciones
    • 11 nov 1992Registro de un cargo (395)
    • 22 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 nov 1992
    Entregado el 11 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Floating charge the company's undertaking property and assets including any uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Ronald George Austin
    Transacciones
    • 11 nov 1992Registro de un cargo (395)
    • 22 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 nov 1992
    Entregado el 11 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Floating charge the company's undertaking property and assets including any uncalled capital.
    Personas con derecho
    • M.B.Owen,P.W.Bullivant and R.G.Austin
    Transacciones
    • 11 nov 1992Registro de un cargo (395)
    • 22 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 09 jul 1992
    Entregado el 14 jul 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All patents,trade marks....etc. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 14 jul 1992Registro de un cargo (395)
    • 05 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0