GIGAWAVE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGIGAWAVE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02704269
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GIGAWAVE LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra GIGAWAVE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    12 Horizon Business Village
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    Surrey
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GIGAWAVE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GIGAWAVE ANTENNAS LIMITED07 abr 199207 abr 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GIGAWAVE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GIGAWAVE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13
    A9CT68UG

    Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X99ZNU7L

    Nombramiento de Mr Graham Michael Pitman como director el 26 jun 2020

    2 páginasAP01
    X9859QBK

    Cese del nombramiento de Robin Beatham Howe como director el 25 jun 2020

    1 páginasTM01
    X9859PZM

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600
    A8GBOVIY

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 01 oct 2019

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    7 páginasLIQ01
    A8FH02SX

    Notification de Legacy Broadcast International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC02
    X8AGKQJV

    Cessation de Pebble Beach Systems Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 jul 2019

    1 páginasPSC07
    X8AGKO16

    Modification des détails de Legacy Broadcast International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 jul 2019

    2 páginasPSC05
    X8ADSDUX

    Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01
    X8AB8XRV

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    8 páginasAA
    A83YV3VM

    Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01
    X81P9SRK

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    8 páginasAA
    A7DAAEN6

    Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01
    X725T4E0

    Modification des détails de Legacy Broadcast International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 ago 2017

    2 páginasPSC05
    X6X0AOYZ

    Domicilio social registrado cambiado de 12 Horizon Business Village 1 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TJ England a 12 Horizon Business Village 1 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TJ el 03 ago 2017

    1 páginasAD01
    X6C0DY20

    Domicilio social registrado cambiado de Chilton House Charnham Lane Hungerford Berkshire RG17 0EY England a 12 Horizon Business Village 1 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TJ el 03 ago 2017

    1 páginasAD01
    X6C0D7BV

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    8 páginasAA
    A676JZTL

    Nombramiento de Mr John Charles Varney como director el 08 may 2017

    2 páginasAP01
    X66PC7NC

    Cese del nombramiento de John Eric Hawkins como director el 08 may 2017

    1 páginasTM01
    X66PC1LM

    Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01
    X64NUZ5C

    Domicilio social registrado cambiado de Chilton House Charnham Lane Hungerford Berkshire RG17 0EY England a Chilton House Charnham Lane Hungerford Berkshire RG17 0EY el 16 mar 2017

    1 páginasAD01
    X62BQ2OQ

    Domicilio social registrado cambiado de Marlborough House Charnham Lane Hungerford Berkshire RG17 0EY a Chilton House Charnham Lane Hungerford Berkshire RG17 0EY el 16 mar 2017

    1 páginasAD01
    X62BPYD4

    ¿Quiénes son los directivos de GIGAWAVE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PITMAN, Graham Michael
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    12 Horizon Business Village
    Surrey
    England
    Director
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    12 Horizon Business Village
    Surrey
    England
    EnglandBritishDirector13368750002
    VARNEY, John Charles
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    12 Horizon Business Village
    Surrey
    England
    Director
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    12 Horizon Business Village
    Surrey
    England
    EnglandBritishDirector119483100002
    BARCZYNSKI, Janice Lesley
    5a Robinsbridge Road
    Coggeshall
    CO6 1UL Colchester
    Essex
    Secretario
    5a Robinsbridge Road
    Coggeshall
    CO6 1UL Colchester
    Essex
    BritishSecretary6656030002
    DAVIES, Ian Gerard
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    United Kingdom
    British171953430001
    TRUMPER, James Ronald
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    Secretario
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    British160888980001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARCZYNSKI, Henry Adam
    5a Robinsbridge Road
    Coggeshall
    CO6 1UL Colchester
    Essex
    Director
    5a Robinsbridge Road
    Coggeshall
    CO6 1UL Colchester
    Essex
    FranceBritishDevelopment Manager61271820008
    BARCZYNSKI, Henry Adam
    37a Stoneham Street
    Coggeshall
    CO6 1UH Colchester
    Essex
    Director
    37a Stoneham Street
    Coggeshall
    CO6 1UH Colchester
    Essex
    BritishSelf Employed61271820001
    BARCZYNSKI, Henry Adam
    37a Stoneham Street
    Coggeshall
    CO6 1UH Colchester
    Essex
    Director
    37a Stoneham Street
    Coggeshall
    CO6 1UH Colchester
    Essex
    BritishAntenna Designer61271820001
    BARCZYNSKI, Janice Lesley
    5a Robinsbridge Road
    Coggeshall
    CO6 1UL Colchester
    Essex
    Director
    5a Robinsbridge Road
    Coggeshall
    CO6 1UL Colchester
    Essex
    United KingdomBritishSecretary6656030002
    BARCZYNSKI, Janice Lesley
    37a Stoneham Street
    Coggeshall
    CO6 1UH Colchester
    Essex
    Director
    37a Stoneham Street
    Coggeshall
    CO6 1UH Colchester
    Essex
    BritishSecretary6656030001
    BARCZYNSKI, Janice Lesley
    37a Stoneham Street
    Coggeshall
    CO6 1UH Colchester
    Essex
    Director
    37a Stoneham Street
    Coggeshall
    CO6 1UH Colchester
    Essex
    BritishSecretary6656030001
    BRADBURY, Patrick John
    18 Old Oak Drive North
    Palm Coast
    Fl 32137
    Usa
    Director
    18 Old Oak Drive North
    Palm Coast
    Fl 32137
    Usa
    UsaAmericanSales Manager76261320002
    CLIFFORD, Simon Timothy
    Lime Tree House
    5 The Street, Brettenham
    IP7 7QP Ipswich
    Suffolk
    Director
    Lime Tree House
    5 The Street, Brettenham
    IP7 7QP Ipswich
    Suffolk
    United KingdomUnited KingdomManaging Director Gigawave Lim119538320001
    DAVIES, Ian Gerard
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector163213870001
    DAVIS, Graham
    64 Hillside Gardens
    CM7 1DJ Braintree
    Essex
    Director
    64 Hillside Gardens
    CM7 1DJ Braintree
    Essex
    BritishElectric Design Engineer52351630002
    DEDHAR, Amin Sadrudin
    Seven Gables
    Boxted Cross
    CO4 5SF Colchester
    Essex
    Director
    Seven Gables
    Boxted Cross
    CO4 5SF Colchester
    Essex
    United KingdomBritishCommercial Manager113798290001
    DERRY, Simon John
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    Director
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive89703280001
    HAERTEL, Peter
    42 Warren Lingley Way
    CO5 0FE Tiptree
    Essex
    Director
    42 Warren Lingley Way
    CO5 0FE Tiptree
    Essex
    United KingdomBritishProduction Manager62048480003
    HAWKINS, John Eric
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Chilton House
    Berkshire
    England
    Director
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Chilton House
    Berkshire
    England
    EnglandBritishDirector53688120001
    HOWE, Robin Beatham
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    12 Horizon Business Village
    Surrey
    England
    Director
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    12 Horizon Business Village
    Surrey
    England
    EnglandBritishDirector106802100001
    JOHNSON, Nicola Jayne
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    Uk
    Director
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    Uk
    UkBritishGroup Financial Controller200467770001
    LAY, Christopher Robert
    21 Moor End
    Eaton Bray
    LU6 2HN Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    21 Moor End
    Eaton Bray
    LU6 2HN Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishElectronics Engineer96287460001
    NORRIDGE, Paul
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    United Kingdom
    UkBritishDirector159468570002
    RUDD, Stephen
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector160369670002
    TRUMPER, James Ronald
    Charnham
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Charnham
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector64931910002
    WALTON, James Martin
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    Director
    Charnham Lane
    RG17 0EY Hungerford
    Marlborough House
    Berkshire
    EnglandBritishChief Financial Officer178766860001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GIGAWAVE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    12 Horizon Business Village
    Surrey
    England
    06 abr 2016
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    12 Horizon Business Village
    Surrey
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies House Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04082188
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    12 Horizon Business Village
    Surrey
    England
    06 abr 2016
    1 Brooklands Road
    KT13 0TJ Weybridge
    12 Horizon Business Village
    Surrey
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies House Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02074604
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene GIGAWAVE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 29 sept 2010
    Entregado el 30 sept 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligor or any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts and uncalled capital see image for full details.
    Personas con derecho
    • Centric Spv 1 Limited
    Transacciones
    • 30 sept 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 22 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creado el 27 ene 2006
    Entregado el 31 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits now and in the future credited to account designation 89048393 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 31 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 16 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 01 may 2001
    Entregado el 05 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a 5 middle king cressing road braintree essex t/n EX501925. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 16 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 12 abr 2001
    Entregado el 18 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 16 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene GIGAWAVE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    01 oct 2019Inicio de la liquidación
    23 dic 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Steven Sherry
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0