GIGAWAVE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | GIGAWAVE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02704269 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GIGAWAVE LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra GIGAWAVE LIMITED?
Dirección de la sede social | 12 Horizon Business Village 1 Brooklands Road KT13 0TJ Weybridge Surrey England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GIGAWAVE LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
GIGAWAVE ANTENNAS LIMITED | 07 abr 1992 | 07 abr 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GIGAWAVE LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GIGAWAVE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 8 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Graham Michael Pitman como director el 26 jun 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robin Beatham Howe como director el 25 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Notification de Legacy Broadcast International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Pebble Beach Systems Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 jul 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Modification des détails de Legacy Broadcast International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 jul 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Legacy Broadcast International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 ago 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 12 Horizon Business Village 1 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TJ England a 12 Horizon Business Village 1 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TJ el 03 ago 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Chilton House Charnham Lane Hungerford Berkshire RG17 0EY England a 12 Horizon Business Village 1 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TJ el 03 ago 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Charles Varney como director el 08 may 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Eric Hawkins como director el 08 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Chilton House Charnham Lane Hungerford Berkshire RG17 0EY England a Chilton House Charnham Lane Hungerford Berkshire RG17 0EY el 16 mar 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Marlborough House Charnham Lane Hungerford Berkshire RG17 0EY a Chilton House Charnham Lane Hungerford Berkshire RG17 0EY el 16 mar 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GIGAWAVE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PITMAN, Graham Michael | Director | 1 Brooklands Road KT13 0TJ Weybridge 12 Horizon Business Village Surrey England | England | British | Director | 13368750002 | ||||
VARNEY, John Charles | Director | 1 Brooklands Road KT13 0TJ Weybridge 12 Horizon Business Village Surrey England | England | British | Director | 119483100002 | ||||
BARCZYNSKI, Janice Lesley | Secretario | 5a Robinsbridge Road Coggeshall CO6 1UL Colchester Essex | British | Secretary | 6656030002 | |||||
DAVIES, Ian Gerard | Secretario | Charnham Lane RG17 0EY Hungerford Marlborough House Berkshire United Kingdom | British | 171953430001 | ||||||
TRUMPER, James Ronald | Secretario | Charnham Lane RG17 0EY Hungerford Marlborough House Berkshire | British | 160888980001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BARCZYNSKI, Henry Adam | Director | 5a Robinsbridge Road Coggeshall CO6 1UL Colchester Essex | France | British | Development Manager | 61271820008 | ||||
BARCZYNSKI, Henry Adam | Director | 37a Stoneham Street Coggeshall CO6 1UH Colchester Essex | British | Self Employed | 61271820001 | |||||
BARCZYNSKI, Henry Adam | Director | 37a Stoneham Street Coggeshall CO6 1UH Colchester Essex | British | Antenna Designer | 61271820001 | |||||
BARCZYNSKI, Janice Lesley | Director | 5a Robinsbridge Road Coggeshall CO6 1UL Colchester Essex | United Kingdom | British | Secretary | 6656030002 | ||||
BARCZYNSKI, Janice Lesley | Director | 37a Stoneham Street Coggeshall CO6 1UH Colchester Essex | British | Secretary | 6656030001 | |||||
BARCZYNSKI, Janice Lesley | Director | 37a Stoneham Street Coggeshall CO6 1UH Colchester Essex | British | Secretary | 6656030001 | |||||
BRADBURY, Patrick John | Director | 18 Old Oak Drive North Palm Coast Fl 32137 Usa | Usa | American | Sales Manager | 76261320002 | ||||
CLIFFORD, Simon Timothy | Director | Lime Tree House 5 The Street, Brettenham IP7 7QP Ipswich Suffolk | United Kingdom | United Kingdom | Managing Director Gigawave Lim | 119538320001 | ||||
DAVIES, Ian Gerard | Director | Charnham Lane RG17 0EY Hungerford Marlborough House Berkshire United Kingdom | England | British | Director | 163213870001 | ||||
DAVIS, Graham | Director | 64 Hillside Gardens CM7 1DJ Braintree Essex | British | Electric Design Engineer | 52351630002 | |||||
DEDHAR, Amin Sadrudin | Director | Seven Gables Boxted Cross CO4 5SF Colchester Essex | United Kingdom | British | Commercial Manager | 113798290001 | ||||
DERRY, Simon John | Director | Charnham Lane RG17 0EY Hungerford Marlborough House Berkshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 89703280001 | ||||
HAERTEL, Peter | Director | 42 Warren Lingley Way CO5 0FE Tiptree Essex | United Kingdom | British | Production Manager | 62048480003 | ||||
HAWKINS, John Eric | Director | Charnham Lane RG17 0EY Hungerford Chilton House Berkshire England | England | British | Director | 53688120001 | ||||
HOWE, Robin Beatham | Director | 1 Brooklands Road KT13 0TJ Weybridge 12 Horizon Business Village Surrey England | England | British | Director | 106802100001 | ||||
JOHNSON, Nicola Jayne | Director | Charnham Lane RG17 0EY Hungerford Marlborough House Berkshire Uk | Uk | British | Group Financial Controller | 200467770001 | ||||
LAY, Christopher Robert | Director | 21 Moor End Eaton Bray LU6 2HN Dunstable Bedfordshire | England | British | Electronics Engineer | 96287460001 | ||||
NORRIDGE, Paul | Director | Charnham Lane RG17 0EY Hungerford Marlborough House Berkshire United Kingdom | Uk | British | Director | 159468570002 | ||||
RUDD, Stephen | Director | Charnham Lane RG17 0EY Hungerford Marlborough House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 160369670002 | ||||
TRUMPER, James Ronald | Director | Charnham RG17 0EY Hungerford Marlborough House Berkshire United Kingdom | England | British | Director | 64931910002 | ||||
WALTON, James Martin | Director | Charnham Lane RG17 0EY Hungerford Marlborough House Berkshire | England | British | Chief Financial Officer | 178766860001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GIGAWAVE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pebble Beach Systems Group Plc | 06 abr 2016 | 1 Brooklands Road KT13 0TJ Weybridge 12 Horizon Business Village Surrey England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Legacy Broadcast International Limited | 06 abr 2016 | 1 Brooklands Road KT13 0TJ Weybridge 12 Horizon Business Village Surrey England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene GIGAWAVE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Creado el 29 sept 2010 Entregado el 30 sept 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the obligor or any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts and uncalled capital see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Charge of deposit | Creado el 27 ene 2006 Entregado el 31 ene 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All deposits now and in the future credited to account designation 89048393 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 01 may 2001 Entregado el 05 may 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The f/h property k/a 5 middle king cressing road braintree essex t/n EX501925. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 12 abr 2001 Entregado el 18 abr 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene GIGAWAVE LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0