ISIS DIRECT LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ISIS DIRECT LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02706066 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ISIS DIRECT LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ISIS DIRECT LIMITED?
Dirección de la sede social | Players House 300 Attercliffe Common S9 2AG Sheffield United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ISIS DIRECT LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ISIS DIRECT LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 abr 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Arclite House Century Road Peatmoor Swindon SN5 5YN United Kingdom el 06 mar 2013 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Sprot como secretario el 01 mar 2013 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Katharine Sarah Mcintyre como director el 01 mar 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Katharine Mcintyre como secretario el 01 mar 2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Robert Gardner como director el 04 dic 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Katharine Mcintyre como secretario el 01 jun 2012 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Katharine Sarah Mcintyre como director el 01 jun 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Keith John Sadler como director el 31 jul 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Keith John Sadler como secretario el 31 jul 2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 abr 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Estado de capital el 26 abr 2011
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 abr 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Langdon como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Tate como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 abr 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ISIS DIRECT LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPROT, Michael | Secretario | 300 Attercliffe Common S9 2AG Sheffield Players House United Kingdom | 176379090001 | |||||||
GARDNER, Andrew Robert | Director | 300 Attercliffe Common S9 2AG Sheffield Players House United Kingdom | England | British | Director | 174126740001 | ||||
BODDY, James Martin | Secretario | 23 St Pauls Square YO24 4BD York North Yorkshire | British | Director | 80326520002 | |||||
COWAN, Paul | Secretario | 119 Cannonbury Avenue HA5 1TR Pinner Middlesex | British | Company Director | 6699820001 | |||||
GUEST, Sarah Elizabeth | Secretario | Coopers Close OX33 1UA Littleworth 24 Oxford | British | Director | 158967330001 | |||||
HOLT, Jason Christopher | Secretario | 4 Popes Court Whelford GL7 4DZ Fairford Gloucestershire | British | Director | 36156330002 | |||||
MCINTYRE, Katharine | Secretario | Century Road Peatmoor SN5 5YN Swindon Arclite House United Kingdom | 173423120001 | |||||||
MINNS, Gregory Leslie John | Secretario | 113 Paddick Drive RG6 4HF Lower Earley Berkshire | British | Director | 72170360001 | |||||
SADLER, Keith John | Secretario | 3 Clifton High Grove Stoke Bishop BS9 1TU Bristol | British | Director | 73173100007 | |||||
TATE, Christopher Ian | Secretario | 27 Sandhill Drive Alwoodley LS17 8DU Leeds West Yorkshire | British | Director | 73503320001 | |||||
VAN HAEFTEN, Alison Jane | Secretario | Stepaside Cottage Petworth Road Wormley GU8 5TU Godalming Surrey | British | 27259640001 | ||||||
MBC SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Classic House 174-180 Old Street EC1V 9BP London | 900000700001 | |||||||
BENEDICK, Alan Harold | Director | 83 Hartfield Avenue Elstree WD6 3JJ Borehamwood Hertfordshire | British | Company Director | 5335840001 | |||||
BODDY, James Martin | Director | 23 St Pauls Square YO24 4BD York North Yorkshire | England | British | Director | 80326520002 | ||||
COWAN, Paul | Director | 119 Cannonbury Avenue HA5 1TR Pinner Middlesex | England | British | Company Director | 6699820001 | ||||
FOLLETT-HOLT, Michelle | Director | 4 Popes Court Whelford GL7 4DZ Fairford Gloucestershire | British | Sales-Marketing | 66623820003 | |||||
GUEST, Sarah Elizabeth | Director | Coopers Close OX33 1UA Littleworth 24 Oxford | England | British | Director | 158967330001 | ||||
HOLT, Jason Christopher | Director | 4 Popes Court Whelford GL7 4DZ Fairford Gloucestershire | British | Director | 36156330002 | |||||
HUMPHRIS, Alan | Director | 32 Northfield Park UB3 4NU Hayes Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 21067230001 | ||||
LANGDON, Richard Benedict | Director | Little Kimble House Little Kimble HP17 0UF Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 148790870001 | ||||
MCINTYRE, Katharine Sarah | Director | Century Road Peatmoor SN5 5YN Swindon Arclite House United Kingdom | England | British | Director | 53459600006 | ||||
SADLER, Keith John | Director | 3 Clifton High Grove Stoke Bishop BS9 1TU Bristol | England | British | Director | 73173100007 | ||||
TATE, Christopher Ian | Director | 27 Sandhill Drive Alwoodley LS17 8DU Leeds West Yorkshire | England | British | Director | 73503320001 | ||||
VAN HAEFTEN, Alison Jane | Director | Stepaside Cottage Petworth Road Wormley GU8 5TU Godalming Surrey | British | Marketing | 27259640001 | |||||
MBC NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Classic House 174-180 Old Street EC1V 9BP London | 900000690001 |
¿Tiene ISIS DIRECT LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creado el 25 sept 2003 Entregado el 01 oct 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada £4,050 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeverunder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción £4,050 plus vat or the sum equal to half the yearly rent reserved by a lease relating to suite 1 windrush court high street witney oxfordshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Rent deposit deed | Creado el 10 ago 1998 Entregado el 18 ago 1998 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the deed | |
Breve descripción £3600 plus vat paid into the account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0