TANGIBLE FINANCIAL LIMITED

TANGIBLE FINANCIAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTANGIBLE FINANCIAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02708053
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TANGIBLE FINANCIAL LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TANGIBLE FINANCIAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    7 Midford Place
    W1T 5BG London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TANGIBLE FINANCIAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CCHM:PING LIMITED27 sept 200427 sept 2004
    CAMP CHIPPERFIELD HILL MURRAY LIMITED25 abr 199725 abr 1997
    HILL MURRAY LIMITED13 abr 199213 abr 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TANGIBLE FINANCIAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TANGIBLE FINANCIAL LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TANGIBLE FINANCIAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 13 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 jun 2014

    Estado de capital el 09 jun 2014

    • Capital: GBP .02
    SH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 13 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    10 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Interim dividend in specie 17/12/2010
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Dividend to be paid 17/12/2010
    RES13

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Estado de capital el 17 dic 2010

    • Capital: GBP 0.02
    4 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Nombramiento de Mr Mark Bentley como secretario

    1 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Mark Scott como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Shelley Watkin como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Shelley Watkin como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Spooner como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Avril Ellis como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de TANGIBLE FINANCIAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BENTLEY, Mark
    Midford Place
    W1T 5BG London
    7
    Secretario
    Midford Place
    W1T 5BG London
    7
    156447920001
    BENTLEY, Mark
    Midford Place
    W1T 5BG London
    7
    Director
    Midford Place
    W1T 5BG London
    7
    EnglandBritishDirector121012880001
    SCOTT, Mark Coleridge
    Midford Place
    W1T 5BG London
    7
    Director
    Midford Place
    W1T 5BG London
    7
    EnglandBritishCompany Director132523740001
    CLARKE, Geoffrey Ernest
    16 Boston Gardens
    Hanwell
    W7 2AN London
    Secretario
    16 Boston Gardens
    Hanwell
    W7 2AN London
    British32953690001
    DAVIES, Julian Lyndon
    Westbush House Hailey Lane
    Hailey
    SG13 7NY Hertford
    Hertfordshire
    Secretario
    Westbush House Hailey Lane
    Hailey
    SG13 7NY Hertford
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant55866800001
    DAVIES, Julian Lyndon
    Westbush House Hailey Lane
    Hailey
    SG13 7NY Hertford
    Hertfordshire
    Secretario
    Westbush House Hailey Lane
    Hailey
    SG13 7NY Hertford
    Hertfordshire
    British55866800001
    NEEVES, Barry John Richard
    Wellmore Cricket Hill Lane
    GU46 6BA Yateley
    Hampshire
    Secretario
    Wellmore Cricket Hill Lane
    GU46 6BA Yateley
    Hampshire
    BritishFinance Director100895050001
    TULLIS, Neil Donaldson
    Chimneys 59 Greenways
    BR3 3NQ Beckenham
    Kent
    Secretario
    Chimneys 59 Greenways
    BR3 3NQ Beckenham
    Kent
    BritishChartered Accoutant36303800001
    WATKIN, Shelley Dawn
    The Avenue
    BR3 5DG Beckenham
    23c
    Kent
    United Kingdom
    Secretario
    The Avenue
    BR3 5DG Beckenham
    23c
    Kent
    United Kingdom
    BritishDirector121423630001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    ANTENEN, Simon Anthony John
    9 Marham Gardens
    SW18 3JZ London
    Director
    9 Marham Gardens
    SW18 3JZ London
    BritishAdvertising76415590001
    BEVACQUA, Richard Domenico
    Oast House
    Shrub Lane
    TN19 7EB Burwash
    East Sussex
    Director
    Oast House
    Shrub Lane
    TN19 7EB Burwash
    East Sussex
    EnglandBritishDirector94558390001
    BOND, Jennifer Kate
    1 Oxberry Avenue
    SW6 5SP London
    Director
    1 Oxberry Avenue
    SW6 5SP London
    BritishCompany Director93080650001
    BROOKS, Christopher John
    10 Larksway
    CM23 4DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    10 Larksway
    CM23 4DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccount Director120397720001
    CAMP, Lucian William Newton
    91 Camden Mews
    NW1 9BW London
    Director
    91 Camden Mews
    NW1 9BW London
    United KingdomBritishChairman85350680002
    CHIPPERFIELD, Stephen John
    Greenways
    Cotleigh
    EX14 9HN Honiton
    Devon
    Director
    Greenways
    Cotleigh
    EX14 9HN Honiton
    Devon
    BritishChief Executive23382500001
    CLARKE, Geoffrey Ernest
    16 Boston Gardens
    Hanwell
    W7 2AN London
    Director
    16 Boston Gardens
    Hanwell
    W7 2AN London
    BritishChartered Accountant32953690001
    DALTON, Vanessa Claire
    22 The Gardens
    Tongham
    GU10 1DZ Farnham
    Surrey
    Director
    22 The Gardens
    Tongham
    GU10 1DZ Farnham
    Surrey
    BritishCreative Services Director71832040002
    DARBYSHIRE, Jayne
    14 Trafalgar Court
    Glamis Road
    E1W 3TF London
    Director
    14 Trafalgar Court
    Glamis Road
    E1W 3TF London
    BritishBoard Account Director71832260001
    DAVIES, Julian Lyndon
    Westbush House Hailey Lane
    Hailey
    SG13 7NY Hertford
    Hertfordshire
    Director
    Westbush House Hailey Lane
    Hailey
    SG13 7NY Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant55866800001
    ELLIS, Avril Dawn
    44 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    Director
    44 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    EnglandBritishBusiness Director118041050001
    FENECH, Peter Michael
    10 Stile Hall Gardens
    W4 3BP London
    Director
    10 Stile Hall Gardens
    W4 3BP London
    BritishCompany Director23382510002
    FROST, Matthew
    Pulteney Gardens
    BA2 4HG Bath
    15
    Avon
    Director
    Pulteney Gardens
    BA2 4HG Bath
    15
    Avon
    BritishDirector129597260001
    GORDON, Paul Laurence
    The Cottage
    California Lane
    WD23 1EP Bushey Heath
    The Cottage
    Hertfordshire
    Director
    The Cottage
    California Lane
    WD23 1EP Bushey Heath
    The Cottage
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCeo57855820003
    HALL, David Jenkinson
    3 Cromwell Place
    N6 5HR London
    Director
    3 Cromwell Place
    N6 5HR London
    BritishDirector7785680001
    HENDERSON, Sarah Ann
    11 Porden Road
    Brixton
    SW2 5SA London
    Director
    11 Porden Road
    Brixton
    SW2 5SA London
    EnglandBritishDirector83512510001
    HILL, Christopher John
    14 Bellevue Road
    Ealing
    W13 8DE London
    Director
    14 Bellevue Road
    Ealing
    W13 8DE London
    United KingdomBritishCopywriter47563610001
    HILL, Roderic Gordon
    19 Scarsdale Villas
    W8 6PT London
    Director
    19 Scarsdale Villas
    W8 6PT London
    United KingdomBritishCompany Director32953700001
    INGRAM, Sean Francis
    18 Stoke Row Road
    Peppard Common
    RG9 5EP Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    18 Stoke Row Road
    Peppard Common
    RG9 5EP Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector153514630001
    JACKSON, Elaine Clare
    3 Canonbury Lane
    N1 2AS London
    Director
    3 Canonbury Lane
    N1 2AS London
    BritishAdvertising89109860001
    KIRKBY, James Peter
    6 Well Close
    Leigh
    TN11 8RQ Sevenoaks
    Kent
    Director
    6 Well Close
    Leigh
    TN11 8RQ Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishDirector77848890002
    KNEESHAW, David Quinnell
    15 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    Director
    15 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    BritishCompany Director27336410001
    LEE, Michael
    34 Elsie Road
    SE22 8DX London
    Director
    34 Elsie Road
    SE22 8DX London
    BritishArt Director76415560001
    MURRAY, Alastair Peter
    101 Abbotsbury Road
    W14 8EP London
    Director
    101 Abbotsbury Road
    W14 8EP London
    BritishCompany Director23382550001
    NEEVES, Barry John Richard
    Wellmore Cricket Hill Lane
    GU46 6BA Yateley
    Hampshire
    Director
    Wellmore Cricket Hill Lane
    GU46 6BA Yateley
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director100895050001

    ¿Tiene TANGIBLE FINANCIAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 12 jul 2007
    Entregado el 19 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 13 abr 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 ene 1996
    Entregado el 23 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Coutts & Co.
    Transacciones
    • 23 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 10 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0