DATASERV OMNICO HOLDINGS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | DATASERV OMNICO HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02708087 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DATASERV OMNICO HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra DATASERV OMNICO HOLDINGS LIMITED?
Dirección de la sede social | Unit 5 Radius Park, Faggs Road TW14 0NG Feltham England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DATASERV OMNICO HOLDINGS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
EL CAMINO (HOLDINGS) LIMITED | 04 sept 1996 | 04 sept 1996 |
DATASERV GROUP LIMITED | 07 dic 1992 | 07 dic 1992 |
CLASSEVER LIMITED | 21 abr 1992 | 21 abr 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DATASERV OMNICO HOLDINGS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DATASERV OMNICO HOLDINGS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neal Philip Saunders como director el 09 nov 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Maxwell Graham como director el 09 nov 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Notification de Dataserv Group Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 jul 2017 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Dataserv Group Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 jul 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Dataserv Building Hawthorne Road Staines Middlesex TW18 3AY a Unit 5 Radius Park, Faggs Road Feltham TW14 0NG el 04 abr 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 20 dic 2016
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Debra Elizabeth Chesterfield como director el 10 may 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Debra Elizabeth Chesterfield como director el 15 mar 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Godfrey como director el 25 abr 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Loedolff como director el 29 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Loedolff como director el 26 jun 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 10 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DATASERV OMNICO HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHESTERMAN, Gary Alan | Secretario | 55 Fakenham Way Owlsmoor GU47 0YS Sandhurst Berkshire | British | 40246930002 | ||||||
GRAHAM, Stephen Maxwell | Director | Radius Park, Faggs Road TW14 0NG Feltham Unit 5 England | England | British | Director | 237064630001 | ||||
BOLTON, Patricia Anne | Secretario | Churchfield House Churchfield Lane Benson OX10 6SH Wallingford Oxfordshire | British | 35902320002 | ||||||
TIMON, Niall John | Secretario | 12 St Andrews Close RG45 6UP Crowthorne Berkshire | British | 121183630001 | ||||||
TIMPERLEY, Richard John | Secretario | 20 Bishopdale Drive LS22 5LP Collingham | British | Articled Clerk | 127284690001 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BAKER, Robert John | Director | Moonrakers Corner Harewood Road HP8 4UB Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 30049770002 | ||||
CHESTERFIELD, Debra Elizabeth | Director | Hawthorne Road TW18 3BP Staines-Upon-Thames Dataserv Building England | England | British | Director | 155985500001 | ||||
DYKES, Ronald | Director | 8440 Lazy Oaks Court Atlanta Georgia Usa | Us Citizen | Company Director | 32964650001 | |||||
FINCH, Simon Leigh | Director | West House 16 Broom Water West TW11 9QH Teddington Middlesex | England | United Kingdom | Managing Director | 64779350001 | ||||
FINCH, Simon Leigh | Director | West House 16 Broom Water West TW11 9QH Teddington Middlesex | England | United Kingdom | Accountant | 64779350001 | ||||
GLAYSHER, Victoria Helen Elizabeth | Director | 16 Broom Water West TW11 9QH Teddington Middlesex | England | United Kingdom | Trading Manager | 64778920001 | ||||
GODFREY, Robert | Director | Hawthorne Road TW18 3AY Staines Dataserv Building Middlesex | Germany | British | Chartered Accountant | 155156380001 | ||||
LOCKWOOD, Michael | Director | 21051 Warner Center Lane 91367 Woodland Hills California Usa | Us Citizen | Councel | 45770200003 | |||||
LOEDOLFF, Andrew | Director | Hawthorne Road TW18 3AY Staines Dataserv Building Middlesex | England | British | Businessman | 175723500001 | ||||
MCCORD, Peter Nicholas George | Director | 43 Palace Road KT8 9DN East Molesey Surrey | England | British | Director | 51689350002 | ||||
PHILLIPS, Joanne | Director | Wilberforce Court High Street HU1 1YJ Hull Humberside | British | Articled Clerk | 27843220001 | |||||
SAUNDERS, Neal Philip | Director | Hatchlands Road RH1 6RW Redhill Sterling House | England | British | Broker | 37104910004 | ||||
TIMPERLEY, Richard John | Director | 20 Bishopdale Drive LS22 5LP Collingham | United Kingdom | British | Articled Clerk | 127284690001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DATASERV OMNICO HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dataserv Group Holdings Limited | 07 jul 2017 | Radius Park, Faggs Road TW14 0NG Feltham Unit 5 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Dataserv Group Ltd | 06 abr 2016 | Radius Park, Faggs Road TW14 0NG Feltham Unit 5 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene DATASERV OMNICO HOLDINGS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge over credit balances | Creado el 13 dic 2001 Entregado el 19 dic 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Barclays bank PLC re el camino (holdings) limited business premium account number 80505846. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of charge over credit balances | Creado el 07 nov 2001 Entregado el 13 nov 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The charge creates a fixed charge over all the "deposits" referred to in the schedule: barclays bank PLC re el camino (holdings) limited business premium account account number 80726087.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee and debenture | Creado el 30 abr 1997 Entregado el 09 may 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as defined) under, or pursuant to, the guarantee and debenture (the "secured obligations") | |
Breve descripción Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including goodwill uncalled capital patents buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0