RESPONSE COMPANY LIMITED

RESPONSE COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRESPONSE COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02711414
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RESPONSE COMPANY LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra RESPONSE COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Secure House
    Moorside Road
    S023 7RX Winchester
    Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RESPONSE COMPANY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    POLYMETERS LIMITED05 jun 199205 jun 1992
    AREALEVEL LIMITED01 may 199201 may 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RESPONSE COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RESPONSE COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012

    3 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2012

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 may 2012

    Estado de capital el 04 may 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011

    3 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Sanjaya Singhal el 20 sept 2011

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Mr Peter Wilman el 16 ago 2010

    2 páginasCH03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2010

    3 páginasAA

    legacy

    5 páginasMG01

    Cambio de datos del director Mr Kaushik Ghosh el 26 sept 2010

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de P R I House Moorside Road Winchester Hampshire SO23 7RX el 29 jun 2010

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    9 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    8 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2007

    7 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed polymeters LIMITED\certificate issued on 06/06/07
    2 páginasCERTNM

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de RESPONSE COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILMAN, Peter
    Heath Road
    KT138TS Weybridge
    The Old Post House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Heath Road
    KT138TS Weybridge
    The Old Post House
    Surrey
    United Kingdom
    British6728520001
    GHOSH, Kaushik
    Oakfields
    Allbrook
    SO504RP Eastleigh
    10
    Hampshire
    England
    Director
    Oakfields
    Allbrook
    SO504RP Eastleigh
    10
    Hampshire
    England
    EnglandIndian138818080002
    SINGHAL, Sanjaya
    Moorside Road
    S0237RX Winchester
    Secure House
    Hampshire
    Director
    Moorside Road
    S0237RX Winchester
    Secure House
    Hampshire
    IndiaIndian51868310007
    DICK, Michael John
    76 Heath Road
    GU31 4EJ Petersfield
    Heath House
    Hampshire
    Secretario
    76 Heath Road
    GU31 4EJ Petersfield
    Heath House
    Hampshire
    British30542990002
    PIERCE, Philippa Elinor
    5 Monnow Gardens
    West End
    SO3 3QD Southampton
    Secretario
    5 Monnow Gardens
    West End
    SO3 3QD Southampton
    British36862820001
    STREATFIELD, Paul Richard
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    Secretario
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    British49339260001
    TUTTON, Richard John
    8 Withingham Road
    BH13 6BU Poole
    Dorset
    Secretario
    8 Withingham Road
    BH13 6BU Poole
    Dorset
    British50685530004
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BABEL, Bhagwat Singh
    12 Peninsula Square
    SO23 8GJ Winchester
    Hampshire
    Director
    12 Peninsula Square
    SO23 8GJ Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish70303880005
    DICK, Michael John
    76 Heath Road
    GU31 4EJ Petersfield
    Heath House
    Hampshire
    Director
    76 Heath Road
    GU31 4EJ Petersfield
    Heath House
    Hampshire
    United KingdomBritish30542990002
    FIELDEN, John Spensley
    Downalong
    Higher Metcombe
    EX11 1SL Ottery St. Mary
    Director
    Downalong
    Higher Metcombe
    EX11 1SL Ottery St. Mary
    British5159620002
    PEDDIE, Robert Alan
    24 Quarry Road
    SO23 0JG Winchester
    Hampshire
    Director
    24 Quarry Road
    SO23 0JG Winchester
    Hampshire
    British36719300002
    ST CLAIR, Richard John
    Millstone
    40 Shortheath Crest
    GU9 8SB Farnham
    Surrey
    Director
    Millstone
    40 Shortheath Crest
    GU9 8SB Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish53455290005
    STREATFIELD, Paul Richard
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    Director
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    British49339260001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene RESPONSE COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 09 dic 2010
    Entregado el 10 dic 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 10 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 25 may 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 05 dic 2003
    Entregado el 09 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 09 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 07 mar 1997
    Entregado el 25 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 25 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 16 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 12 sept 1994
    Entregado el 27 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0