RESPONSE COMPANY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RESPONSE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02711414 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RESPONSE COMPANY LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra RESPONSE COMPANY LIMITED?
| Dirección de la sede social | Secure House Moorside Road S023 7RX Winchester Hampshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RESPONSE COMPANY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| POLYMETERS LIMITED | 05 jun 1992 | 05 jun 1992 |
| AREALEVEL LIMITED | 01 may 1992 | 01 may 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RESPONSE COMPANY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RESPONSE COMPANY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2012 | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Sanjaya Singhal el 20 sept 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Peter Wilman el 16 ago 2010 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2010 | 3 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 5 páginas | MG01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Kaushik Ghosh el 26 sept 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de P R I House Moorside Road Winchester Hampshire SO23 7RX el 29 jun 2010 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 may 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009 | 9 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2008 | 8 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2007 | 7 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 7 páginas | 363s | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed polymeters LIMITED\certificate issued on 06/06/07 | 2 páginas | CERTNM | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RESPONSE COMPANY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILMAN, Peter | Secretario | Heath Road KT138TS Weybridge The Old Post House Surrey United Kingdom | British | 6728520001 | ||||||
| GHOSH, Kaushik | Director | Oakfields Allbrook SO504RP Eastleigh 10 Hampshire England | England | Indian | 138818080002 | |||||
| SINGHAL, Sanjaya | Director | Moorside Road S0237RX Winchester Secure House Hampshire | India | Indian | 51868310007 | |||||
| DICK, Michael John | Secretario | 76 Heath Road GU31 4EJ Petersfield Heath House Hampshire | British | 30542990002 | ||||||
| PIERCE, Philippa Elinor | Secretario | 5 Monnow Gardens West End SO3 3QD Southampton | British | 36862820001 | ||||||
| STREATFIELD, Paul Richard | Secretario | 45 Castle Lane Chandlers Ford SO53 4AH Eastleigh Hampshire | British | 49339260001 | ||||||
| TUTTON, Richard John | Secretario | 8 Withingham Road BH13 6BU Poole Dorset | British | 50685530004 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BABEL, Bhagwat Singh | Director | 12 Peninsula Square SO23 8GJ Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 70303880005 | |||||
| DICK, Michael John | Director | 76 Heath Road GU31 4EJ Petersfield Heath House Hampshire | United Kingdom | British | 30542990002 | |||||
| FIELDEN, John Spensley | Director | Downalong Higher Metcombe EX11 1SL Ottery St. Mary | British | 5159620002 | ||||||
| PEDDIE, Robert Alan | Director | 24 Quarry Road SO23 0JG Winchester Hampshire | British | 36719300002 | ||||||
| ST CLAIR, Richard John | Director | Millstone 40 Shortheath Crest GU9 8SB Farnham Surrey | United Kingdom | British | 53455290005 | |||||
| STREATFIELD, Paul Richard | Director | 45 Castle Lane Chandlers Ford SO53 4AH Eastleigh Hampshire | British | 49339260001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Tiene RESPONSE COMPANY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 09 dic 2010 Entregado el 10 dic 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 05 dic 2003 Entregado el 09 dic 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 07 mar 1997 Entregado el 25 mar 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 12 sept 1994 Entregado el 27 sept 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0