ZONEARCHIVE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ZONEARCHIVE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02713276 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ZONEARCHIVE LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra ZONEARCHIVE LIMITED?
Dirección de la sede social | 2nd Floor Victoria Wharf, 4 The Embankment Sovereign Street LS1 4BA Leeds United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ZONEARCHIVE LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
ZONEARCHIVE PLC | 31 jul 2009 | 31 jul 2009 |
STERLING CAPITOL PLC | 24 jun 1992 | 24 jun 1992 |
LAURELWOOD LIMITED | 08 may 1992 | 08 may 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ZONEARCHIVE LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ZONEARCHIVE LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 08 may 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 22 may 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 08 may 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ZONEARCHIVE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Robert Sydney Murray como director el 25 jul 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael John Heydecke como director el 25 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Certificado de re-registro de Compañía Pública Limitada a Privada | 2 páginas | CERT10 | ||||||||||
Re-registro del Memorándum y Estatutos | 11 páginas | MAR | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Re-registro de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada | páginas | RR02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 may 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Capitol Park Leeds Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 sept 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Michael John Heydecke como director el 19 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Ian Walker como director el 14 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 may 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Catherine Salkeld como director el 14 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de James John Robert Murray como director el 14 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Catherine Salkeld como secretario el 14 dic 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 9 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ZONEARCHIVE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
MURRAY, James John Robert | Director | Victoria Wharf, 4 The Embankment Sovereign Street LS1 4BA Leeds 2nd Floor United Kingdom | Jersey | British | Director | 224269330001 | ||||
MURRAY, Robert Sydney | Director | Victoria Wharf, 4 The Embankment Sovereign Street LS1 4BA Leeds 2nd Floor United Kingdom | Jersey | British | Chairman | 330274410001 | ||||
CROXEN, Martin | Secretario | Lisbon Square LS1 4LY Leeds 1 West Yorkshire United Kingdom | British | Chartered Accountant | 5134770003 | |||||
SALKELD, Catherine | Secretario | Victoria Wharf, 4 The Embankment Sovereign Street LS1 4BA Leeds 2nd Floor United Kingdom | 170421360001 | |||||||
YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
ARMSTRONG, Michael Lars | Director | Gateshill Ripley Road HG5 9HA Knaresborough North Yorkshire | British | Surveyor | 76125250001 | |||||
CARTMELL, Gary Stephen | Director | The White Cross South Road LA1 4XQ Lancaster 327 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 170427540001 | ||||
CROXEN, Barbara Anne | Director | 7 The Oval Guiseley LS20 8JZ Leeds West Yorkshire | British | Secretary | 27512890001 | |||||
CROXEN, Martin | Director | Lisbon Square LS1 4LY Leeds 1 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 5134770003 | ||||
HEYDECKE, Michael John | Director | Victoria Wharf, 4 The Embankment Sovereign Street LS1 4BA Leeds 2nd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 224269340002 | ||||
MURRAY, Robert Sydney, Sir | Director | Route Orange St Brelade JE3 8GP Jersey Les Lumieres | Jersey | British | Company Chairman | 135233390001 | ||||
SALKELD, Catherine | Director | Victoria Wharf, 4 The Embankment Sovereign Street LS1 4BA Leeds 2nd Floor United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 1166020006 | ||||
WALKER, Peter Ian | Director | Victoria Wharf, 4 The Embankment Sovereign Street LS1 4BA Leeds 2nd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 135658510001 | ||||
YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ZONEARCHIVE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitol Park Leeds Limited | 06 abr 2016 | Victoria Wharf, 4 The Embankment Sovereign Street LS1 4BA Leeds 2nd Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene ZONEARCHIVE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities | Creado el 20 jul 2006 Entregado el 26 jul 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the depositor to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 49,000 ordinary shares of £1 each in the the principal held by the depositor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 01 oct 2003 Entregado el 07 oct 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust debenture | Creado el 06 ene 2000 Entregado el 12 ene 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and other costs and expenses of the trustees of settlements under or arising in connection with the indemnities (as defined in the trust debenture) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust debenture | Creado el 31 mar 1998 Entregado el 16 abr 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee) and the trustees or any of them on any account whatsoever (including without limitation under or arising in connection with the indemnities given by the company to the trustees on 31ST march 1998) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings and fixtures. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust debenture | Creado el 04 mar 1996 Entregado el 21 mar 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and the trustees or any of them on any account whatsoever under the terms of the indemnities (as defined therein) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 20 may 1992 Entregado el 01 jun 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0