CARDIF INSURANCE HOLDINGS PLC
Visión general
| Nombre de la empresa | CARDIF INSURANCE HOLDINGS PLC |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad anónima cotizada |
| Número de empresa | 02713318 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CARDIF INSURANCE HOLDINGS PLC?
- Seguros de vida (65110) / Actividades financieras y de seguros
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CARDIF INSURANCE HOLDINGS PLC?
| Dirección de la sede social | 10 Harewood Avenue NW1 6AA London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARDIF INSURANCE HOLDINGS PLC?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CARDIF PINNACLE INSURANCE HOLDINGS PLC | 29 mar 2005 | 29 mar 2005 |
| PINNACLE INSURANCE HOLDINGS PLC | 05 may 1992 | 05 may 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CARDIF INSURANCE HOLDINGS PLC?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARDIF INSURANCE HOLDINGS PLC?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 05 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 19 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 05 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARDIF INSURANCE HOLDINGS PLC?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mrs Sarah Wickett como secretario el 11 sept 2025 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Lisa Marvin como secretario el 04 sept 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 32 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 may 2025 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 08 nov 2024
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 31 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 may 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 16 ago 2023
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Pinnacle House a1 Barnet Way Borehamwood Hertfordshire WD6 2XX a 10 Harewood Avenue London NW1 6AA el 13 may 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Ms Clara Angela Iris Lane como director el 22 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Ms Lisa Marvin como secretario el 22 abr 2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel James Pritchard como director el 22 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Sophie Margaret May como director el 22 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Justin Lorimer como director el 22 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Miles Wigg como director el 22 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Justin Lorimer como secretario el 22 abr 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 39 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Sophie Margaret Luton el 03 mar 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 10 páginas | MA | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Craig Anthony Scarr como director el 14 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Adam Hines como director el 14 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed cardif pinnacle insurance holdings PLC\certificate issued on 29/07/22 | 2 páginas | CERTNM | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CARDIF INSURANCE HOLDINGS PLC?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WICKETT, Sarah | Secretario | NW1 6AA London 10 Harewood Avenue England | 340351340001 | |||||||
| CHEVALET, Stanislas Louis Paul Francois | Director | Rue Du Port 92728 Nanterre Cedex 8 France | France | French | 202561250001 | |||||
| LANE, Clara Angela Iris | Director | Harewood Avenue NW1 6AA London 10 United Kingdom | England | British,Italian | 107200080001 | |||||
| PRITCHARD, Daniel James | Director | Harewood Avenue NW1 6AA London 10 United Kingdom | England | British | 322521850001 | |||||
| CRANSTON, Kareen | Secretario | 2 Mount Pleasant AL3 4QJ St. Albans Hertfordshire | British | 69895760003 | ||||||
| LORIMER, Matthew Justin | Secretario | A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House Hertfordshire | British | 114062220001 | ||||||
| MARVIN, Lisa | Secretario | Harewood Avenue NW1 6AA London 10 United Kingdom | 322525680001 | |||||||
| MILLS, Christopher Simon | Secretario | 28 Beaumont Place Hadley Highstone EN5 4PR Barnet Hertfordshire | British | 16743590007 | ||||||
| CARDIF PINNACLE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Pinnacle House A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Hertfordshire | 108078990002 | |||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| ATKINSON, Natalie Jayne | Director | Al Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House Hertfordshire | England | British | 126577150002 | |||||
| BINET, Gerard | Director | 19 Riute De La Passerelle Le Vesinet 78110 France | French | 116255600001 | ||||||
| BLOXHAM, Peter John | Director | 8 Old Orchards Church Road, Worth RH10 7QA Crawley West Sussex | British | 84073550001 | ||||||
| BOX, Peter John | Director | A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 172092790001 | |||||
| CARTE, Brian Addison | Director | A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House Hertfordshire | United Kingdom | British | 145559220001 | |||||
| CASTAGNO, John | Director | A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House Hertfordshire | United Kingdom | Italian | 89272480003 | |||||
| DREYER, Anthony William | Director | Ashwood Lodge 57 Badgersgate LU6 2BF Dunstable Bedfordshire | England | British | 29398250006 | |||||
| GLEN, Paul Edward | Director | A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House Hertfordshire | England | British | 114777580001 | |||||
| GOLDING, Adam Jon | Director | A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House Hertfordshire | United Kingdom | British | 126538020001 | |||||
| HADERER, Marie | Director | A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House Hertfordshire | United Kingdom | French | 220851490002 | |||||
| HINES, Richard Adam | Director | Pinnacle House A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Hertfordshire | United Kingdom | British | 86600240001 | |||||
| LAROCHE, Jean-Bertrand Marie | Director | 23 Avenue De Segur Paris 75007 France | France | French | 202560650001 | |||||
| LORIMER, Matthew Justin | Director | A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House Hertfordshire United Kingdom | England | British | 197090500001 | |||||
| MAY, Sophie Margaret | Director | Pinnacle House A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Hertfordshire | England | British | 206051110002 | |||||
| MEE, Robert James | Director | A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House Hertfordshire | England | British | 92913850001 | |||||
| MILLS, Christopher Simon | Director | 28 Beaumont Place Hadley Highstone EN5 4PR Barnet Hertfordshire | England | British | 16743590007 | |||||
| PRIESTLEY, Leslie William | Director | 12 Camden Close BR7 5PH Chislehurst Kent | United Kingdom | British | 407320003 | |||||
| RAINGOLD, Gerald Barry | Director | 12 Marston Close Swiss Cottage NW6 4EU London | England | British | 4418620001 | |||||
| RENNIE, Helen Elspeth | Director | Pinnacle House A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Hertfordshire | England | British,Australian | 277732830001 | |||||
| ROCHEZ, Nicholas Dutfield | Director | A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 174024060001 | |||||
| SCARR, Craig Anthony | Director | Pinnacle House A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Hertfordshire | United Kingdom | British | 141533850001 | |||||
| SCHWICK, Christopher John | Director | West Point Newnham Way SG7 5PN Ashwell Hertfordshire | United Kingdom | British | 29398210003 | |||||
| SHACKELL, Ian Richard Charles | Director | A1 Barnet Way WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House Hertfordshire | Great Britain | British | 133745370003 | |||||
| SHUKER, Norman Alan | Director | Fortune House Barnet Lane Elstree WD6 3RH Borehamwood Hertfordshire | United Kingdom | British | 7231070001 | |||||
| SWAIN, Andrew Donald | Director | Wentfords Clare Road CO10 8GY Poslingford Suffolk | British | 114062240001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CARDIF INSURANCE HOLDINGS PLC?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cb (Uk) Limited | 06 abr 2016 | Stangate Crescent WD6 2XX Borehamwood Pinnacle House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Bnp Paribas Cardif | 06 abr 2016 | 1 Boulevard Haussmann 75009 Paris 1 Boulevard Haussmann France | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0