THE FIN MACHINE COMPANY LIMITED

THE FIN MACHINE COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE FIN MACHINE COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02714045
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE FIN MACHINE COMPANY LIMITED?

    • fabricación de maquinaria para la conformación de metales (28410) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra THE FIN MACHINE COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Greater Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE FIN MACHINE COMPANY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ADJUSTGRAPH LIMITED13 may 199213 may 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE FIN MACHINE COMPANY LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2012
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2013
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE FIN MACHINE COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    14 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 ago 2015

    13 páginas4.68

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Informe de progreso del administrador hasta 03 ago 2014

    17 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    1 páginas2.34B

    Informe de progreso del administrador hasta 20 feb 2014

    16 páginas2.24B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    17 páginas2.17B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    8 páginas2.16B

    Domicilio social registrado cambiado de * Unit a, Hall Dene Way Seaham Grange Industrial Estate Seaham County Durham SR7 0PU* el 04 sept 2013

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cese del nombramiento de Christopher Terry como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Terry como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 13 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 jun 2013

    Estado de capital el 05 jun 2013

    • Capital: GBP 35,595
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Matthew James Smith el 01 jun 2013

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de James Marriner como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Clive Nicholson como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Christopher Malcolm Terry como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Clive Nicholson como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Christopher Malcolm Terry como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr David John Jennings como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Keith Stuart Jordan el 20 nov 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    25 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Matthew James Smith el 25 abr 2012

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de THE FIN MACHINE COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JENNINGS, David John
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Greater Manchester
    Director
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Greater Manchester
    United KingdomBritishChief Executive Officer176259610001
    JORDAN, Keith Stuart
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Greater Manchester
    Director
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Greater Manchester
    EnglandBritishCompany Director139201050004
    SMITH, Matthew James
    c/o Foresight Group
    South Park
    TN13 1DU Sevenoaks
    Eca Court
    Kent
    United Kingdom
    Director
    c/o Foresight Group
    South Park
    TN13 1DU Sevenoaks
    Eca Court
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance - Investment Director (Corporate Finance)155625200002
    NICHOLSON, Clive
    Stamford Bridge Road
    Dunnington
    YO19 5LL York
    8
    United Kingdom
    Secretario
    Stamford Bridge Road
    Dunnington
    YO19 5LL York
    8
    United Kingdom
    159536130001
    RUTTER, David
    Seaton Ryde
    Tranwell Woods
    NE61 6AQ Morpeth
    Northumberland
    Secretario
    Seaton Ryde
    Tranwell Woods
    NE61 6AQ Morpeth
    Northumberland
    BritishDirector39487330002
    TERRY, Christopher Malcolm
    Unit A, Hall Dene Way
    Seaham Grange Industrial Estate
    SR7 0PU Seaham
    County Durham
    Secretario
    Unit A, Hall Dene Way
    Seaham Grange Industrial Estate
    SR7 0PU Seaham
    County Durham
    178319980001
    THOMPSON, Chris Scott
    Kingsway North
    Team Valley Trading Estate
    NE11 0EG Gateshead
    Tyne & Wear
    Secretario
    Kingsway North
    Team Valley Trading Estate
    NE11 0EG Gateshead
    Tyne & Wear
    BritishManager42840520002
    THOMPSON, Christopher Scott
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    British42840520001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BILLINGHAM, Craig John
    22 High Stell
    Middleton St George
    DL2 1UN Darlington
    County Durham
    Director
    22 High Stell
    Middleton St George
    DL2 1UN Darlington
    County Durham
    United KingdomBritishCompany Director107626950001
    BUTLER, Gordon William
    Tudor House
    Whitton Village
    TS21 1LQ Stockton Tees
    Cleveland
    Director
    Tudor House
    Whitton Village
    TS21 1LQ Stockton Tees
    Cleveland
    BritishDirector54030270002
    COTTRELL, Brian
    5 Hill Top Grove
    Tingley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    5 Hill Top Grove
    Tingley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishTechnical Director3616680002
    COTTRELL, Brian
    5 Hill Top Grove
    Tingley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    5 Hill Top Grove
    Tingley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishEngineer3616680002
    DIXON, John
    Flat 5 2 Abbotsford Terrace
    Jesmond
    NE2 3AD Newcastle Upon Tyne
    Director
    Flat 5 2 Abbotsford Terrace
    Jesmond
    NE2 3AD Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Director78919480006
    HENRY, Martin David
    Battle Court
    Mill Lane Boroughbridge
    YO51 9LH York
    North Yorkshire
    Director
    Battle Court
    Mill Lane Boroughbridge
    YO51 9LH York
    North Yorkshire
    EnglandBritishEngineer94879590001
    LING, Philip Henry
    The Old Farmhouse
    Cockpole Green
    RG10 8NT Wargrave
    Berkshire
    Director
    The Old Farmhouse
    Cockpole Green
    RG10 8NT Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director2326420001
    MACALLAN, Tom
    Unit A, Hall Dene Way
    Seaham Grange Industrial Estate
    SR7 0PU Seaham
    County Durham
    Director
    Unit A, Hall Dene Way
    Seaham Grange Industrial Estate
    SR7 0PU Seaham
    County Durham
    United KingdomBritishChief Executive Officer162067320001
    MARRINER, James
    7 Victoria Mews
    Jesmond
    NE2 1ER Newcastle
    Tyne & Wear
    Director
    7 Victoria Mews
    Jesmond
    NE2 1ER Newcastle
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishSales Director116264170001
    MUNDY, Andrew Nicholas
    6 Chestnut Close
    DL8 1XL Bedale
    North Yorkshire
    Director
    6 Chestnut Close
    DL8 1XL Bedale
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector96308610001
    NICHOLSON, Clive
    Unit A, Hall Dene Way
    Seaham Grange Industrial Estate
    SR7 0PU Seaham
    County Durham
    Director
    Unit A, Hall Dene Way
    Seaham Grange Industrial Estate
    SR7 0PU Seaham
    County Durham
    United KingdomBritishFinance Director134927080001
    ROSS, Nicholas Robert William
    260 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8RL London
    Director
    260 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8RL London
    EnglandBritishInvestment Manager235844400001
    RUTTER, David
    18 Grove Park Crescent
    Gosforth
    NE3 1BP Newcastle
    Director
    18 Grove Park Crescent
    Gosforth
    NE3 1BP Newcastle
    United KingdomBritishManaging Dir125292600001
    RUTTER, David
    Seaton Ryde
    Tranwell Woods
    NE61 6AQ Morpeth
    Northumberland
    Director
    Seaton Ryde
    Tranwell Woods
    NE61 6AQ Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritishDirector39487330002
    STANLEY, Roy Robert
    7 Westfield Avenue
    Gosforth
    NE3 4YH Newcastle Upon Tyne
    Director
    7 Westfield Avenue
    Gosforth
    NE3 4YH Newcastle Upon Tyne
    BritishManager42840530001
    STANLEY, Roy Robert Edward
    7 Westfield Avenue
    Gosforth
    NE3 4YH Newcastle Upon Tyne
    Director
    7 Westfield Avenue
    Gosforth
    NE3 4YH Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Director8609980001
    TERRY, Christopher Malcolm, Mr.
    Unit A, Hall Dene Way
    Seaham Grange Industrial Estate
    SR7 0PU Seaham
    County Durham
    Director
    Unit A, Hall Dene Way
    Seaham Grange Industrial Estate
    SR7 0PU Seaham
    County Durham
    EnglandBritishChief Financial Officer60746700002
    THOMPSON, Chris Scott
    Kingsway North
    Team Valley Trading Estate
    NE11 0EG Gateshead
    Tyne & Wear
    Director
    Kingsway North
    Team Valley Trading Estate
    NE11 0EG Gateshead
    Tyne & Wear
    BritishManager42840520002
    THOMPSON, Christopher Scott
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Director
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    BritishEngineer42840520001
    WALLEY, Clive
    24 Craven Way
    Boroughbridge
    YO51 9UR York
    Director
    24 Craven Way
    Boroughbridge
    YO51 9UR York
    EnglandEnglishCompany Director67457790002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene THE FIN MACHINE COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 27 jul 2012
    Entregado el 08 ago 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or by any other mortgagor to any noteholder or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Foresight 4 Vct PLC as Security Trustee (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 08 ago 2012Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 06 oct 2011
    Entregado el 18 oct 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Acuity Vct 3 PLC
    Transacciones
    • 18 oct 2011Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 06 oct 2011
    Entregado el 18 oct 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Foresight 5 Vct PLC
    Transacciones
    • 18 oct 2011Registro de un cargo (MG01)
    Mortgage of policy
    Creado el 02 nov 2007
    Entregado el 15 nov 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The policy. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 15 nov 2007Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 02 nov 2007
    Entregado el 14 nov 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 14 nov 2007Registro de un cargo (395)
    Chattel mortgage
    Creado el 28 sept 2005
    Entregado el 05 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fin machine co, high volume fin machine, s/no 154772000; jones and shipman, 18"X6" horizontal spindle surface grinder, s/no B075038; jones and shipman,18"X6" horizontal spindle surface grinder s/no B096507 for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 28 sept 2005
    Entregado el 05 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assignment of debts by way of security
    Creado el 05 dic 2003
    Entregado el 16 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the companys right title benefit and interest in and all money payable to or to the account of the company in respect of the debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assignment
    Creado el 03 oct 2003
    Entregado el 10 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the companys right title benefit and interest in and all money payable to or to the account of company in respect of the debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 03 oct 2003
    Entregado el 10 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The mortgaged chattels being union bft 80/2 horizontal borer, serial no: 25942, equipment: newall DP7 3 axis D.R.o, union bft 80/2 horizontal borer, serial no: 25772, equipment: newall DP7 2 axis D.R.o, kearns model 720 traversing spindle only, horizontal borer, serial no: 5362, est date:1961 for further details of the chattels charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 04 sept 2003
    Entregado el 09 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fin press incorporating tooling and sub assembly numbered 17675, 17676, 17677, 17678, 17679, 17680, 17681, 17682, 17683, 17684, 17685, 17686, 17687, 17688, 17689, 17690, 17691, 18264, 18674 situated at unit 1 halldene way seaham grange undustrial seaham.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 21 ago 2003
    Entregado el 28 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The plant, machinery, chattels or other equipment being deltronic DH400 profile projector s/no 298055853 equipment deltronic mpc-5 2 axis D.R.o, jones and shipman 540P 18" x 6" horizontal spindle surface grinder s/no B096507 date of manufacture: 1980 equipment: diaform attachment, s/no 1869 5/1, optical dividing head, s/no 2157, heidenhain 1 axis D.R.o and dust extraction unit (for details of further chattels charged please refer to form 395) together with all additions, alterations, accessories, replacements and renewals from time to time thereto. The benefit of any guarantee, warranty or other obligation in relation to the mortgaged chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assignment of debts by way of security
    Creado el 21 ago 2003
    Entregado el 28 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the company's right, title, benefit and interest in and all money payable to or to the account of company in respect of the debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 15 oct 1998
    Entregado el 21 oct 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Various chattels listed in schedule of form 395 relative to the charge headed by bridgeport interact T20X vertical machinery centre serial no.71224 With 20 unit tool holder heidenhain TNC2500 3 axis dro and ewquipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 oct 1998Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 dic 1993
    Entregado el 16 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 16 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 29 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 oct 1992
    Entregado el 10 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings on the east side of salters lane,sedgefield durham. T/n DU57018.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 nov 1992Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 oct 1992
    Entregado el 05 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 nov 1992Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 21 ago 1992
    Entregado el 29 ago 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the loose plant machinery tools equipment vehicles and other chattels of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    Personas con derecho
    • Express Engineering (Thompson) Limited
    Transacciones
    • 29 ago 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 jul 1992
    Entregado el 15 jul 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £240,000 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Land and buildings on the east side of salters lane,sedgefield.
    Personas con derecho
    • Darcham Limited
    Transacciones
    • 15 jul 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene THE FIN MACHINE COMPANY LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 ago 2013Inicio de la administración
    04 ago 2014Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Joseph Peter Francis Mclean
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne
    Profesional
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne
    Christopher Petts
    Grant Thornton Uk Llp Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    2
    FechaTipo
    03 sept 2016Fecha de disolución
    04 ago 2014Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Joseph Peter Francis Mclean
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne
    Liquidador propuesto
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne
    Christopher Petts
    Grant Thornton Uk Llp Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    Liquidador propuesto
    Grant Thornton Uk Llp Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    Christopher Petts
    Grant Thornton Uk Llp Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    Joseph Peter Francis Mclean
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne
    Profesional
    Grant Thornton
    Earl Grey House
    NE1 6EF 75-85 Grey Street
    Newcastle Upon Tyne

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0