CGX REALISATIONS LIMITED

CGX REALISATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCGX REALISATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02714095
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CGX REALISATIONS LIMITED?

    • Otras industrias manufactureras n.c.p. (32990) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra CGX REALISATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CGX REALISATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CHROMOGENEX TECHNOLOGIES LIMITED15 ago 200515 ago 2005
    EUPHOTONICS LIMITED16 abr 200316 abr 2003
    PHOTONICS LIMITED25 feb 200325 feb 2003
    ICN PHOTONICS LIMITED13 sept 200013 sept 2000
    SLS BIOPHILE LIMITED17 feb 199917 feb 1999
    SLS TECHNOLOGIES LIMITED14 ene 199914 ene 1999
    SLS BIOPHILE LIMITED21 ago 199621 ago 1996
    SLS (WALES) LIMITED24 nov 199224 nov 1992
    NOTICEGRAND LIMITED13 may 199213 may 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CGX REALISATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CGX REALISATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de la administración a la disolución

    14 páginasAM23

    Informe de progreso del administrador

    16 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    17 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador hasta 14 mar 2017

    15 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 14 sept 2016

    19 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 08 jun 2016

    20 páginas2.24B

    Cese del nombramiento de Peter William Mcguinness como director el 27 may 2016

    2 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 10 mar 2016

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cese del nombramiento de Stephen John Ellis como director el 31 mar 2016

    2 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 11 mar 2016

    RES15

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    9 páginas2.16B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    19 páginas2.17B

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 1 & 2 Heol Rhosyn Parc Dafen Llanelli Carmarthenshire SA14 8QG a C/O Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB el 29 dic 2015

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    26 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 may 2015

    Estado de capital el 11 may 2015

    • Capital: GBP 524,129.5
    SH01

    Cese del nombramiento de Kevin Donald Williams como director el 31 ene 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gerwyn John Miles como director el 31 ene 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gerwyn John Miles como secretario el 31 ene 2015

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    25 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CGX REALISATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOOD, Elizabeth Rhoda
    8 Caesars Gate
    NN13 7NH Brackley
    Northamptonshire
    Secretario
    8 Caesars Gate
    NN13 7NH Brackley
    Northamptonshire
    British106249340001
    HUGHES, Ian
    22 Clos Leighton Davies
    Gowerton
    SA4 3GG Swansea
    Secretario
    22 Clos Leighton Davies
    Gowerton
    SA4 3GG Swansea
    British34575790001
    MAIR, Barrie, Dr
    Wych Elm
    Fishery Road
    SL6 1UP Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    Wych Elm
    Fishery Road
    SL6 1UP Maidenhead
    Berkshire
    British64128670001
    MILES, Gerwyn John
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    Secretario
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    185755600001
    MORGAN, David Gareth
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    Secretario
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    British65312520002
    PECKHAM, David Hywel
    38 Parc Howard Avenue
    SA15 3JY Llanelli
    Dyfed
    Secretario
    38 Parc Howard Avenue
    SA15 3JY Llanelli
    Dyfed
    Welsh34106670001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CAMERON, Allan
    33 Llythrid Avenue
    Uplands
    SA2 0JJ Swansea
    Director
    33 Llythrid Avenue
    Uplands
    SA2 0JJ Swansea
    British54654800002
    CHAPPLE, Timothy Jonathan
    18 Roger Beck Way
    Sketty
    SA2 0JF Swansea
    Director
    18 Roger Beck Way
    Sketty
    SA2 0JF Swansea
    British28933940002
    CLEMENT, Robert Marc
    11 Plas Road
    Rhos Pontardawe
    SA8 3HD Swansea
    Director
    11 Plas Road
    Rhos Pontardawe
    SA8 3HD Swansea
    United KingdomBritish25145750001
    ELLIS, Stephen John
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Director
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritish89725230001
    HOSKIN, John David
    Bourne Bank
    Hedsor Road
    SL8 5EE Bourne End
    Buckinghamshire
    Director
    Bourne Bank
    Hedsor Road
    SL8 5EE Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish30414350001
    JONES, Gary Lewis
    48 Neath Road
    Resolven
    SA11 4AH Neath
    West Glamorgan
    Director
    48 Neath Road
    Resolven
    SA11 4AH Neath
    West Glamorgan
    British65958200001
    LUNN, David Arthur
    3rd Floor Euro Canadian Centre
    Marlborough Street
    N 4901 Nassau
    Bahamas
    Bahamas
    Director
    3rd Floor Euro Canadian Centre
    Marlborough Street
    N 4901 Nassau
    Bahamas
    Bahamas
    Bahamian28967300002
    MACDONALD, Bill Alan
    PO BOX 675493
    Rancho Santa Fe
    Ca 92067
    United States Of America
    Director
    PO BOX 675493
    Rancho Santa Fe
    Ca 92067
    United States Of America
    American79392050001
    MAIR, Barrie, Dr
    Wych Elm
    Fishery Road
    SL6 1UP Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Wych Elm
    Fishery Road
    SL6 1UP Maidenhead
    Berkshire
    British64128670001
    MAIR, Jill Margaret
    Wych Elm
    Fishery Road
    SL6 1UP Bray
    Berkshire
    Director
    Wych Elm
    Fishery Road
    SL6 1UP Bray
    Berkshire
    British28887650001
    MCGUINNESS, Peter William
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Director
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritish97826790005
    MEHL, Thomas
    1015 Highway
    337 Old Bronson Road
    32669 Newberry
    Alachua
    Usa
    Director
    1015 Highway
    337 Old Bronson Road
    32669 Newberry
    Alachua
    Usa
    American52304100001
    MILES, Gerwyn John
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    Director
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    WalesBritish46422480002
    MORGAN, David Gareth
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    Director
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    WalesBritish65312520002
    PRICE, John Duncan
    12 Georgian Way
    HA1 3LF Harrow
    Middlesex
    Director
    12 Georgian Way
    HA1 3LF Harrow
    Middlesex
    EnglandBritish38774440001
    ROOSJE, Harry A
    31 New Dawn
    92620 Irvine
    California
    Usa
    Director
    31 New Dawn
    92620 Irvine
    California
    Usa
    American90485720001
    ROVALO LOPEZ DE LINARES, Francisco Javier, Doctor
    Calzada Tlalpan 2021
    04040 Mexo Df
    FOREIGN Mexico City
    Mexico
    Director
    Calzada Tlalpan 2021
    04040 Mexo Df
    FOREIGN Mexico City
    Mexico
    Mexican70935860001
    TAYLOR, Mark
    45 Bridgeport
    Newport Coast
    California
    92657
    Usa
    Director
    45 Bridgeport
    Newport Coast
    California
    92657
    Usa
    American70935810001
    TIMMONS, Christopher Miles
    25261 Vealsquez Road
    Laguna Hills
    Ca 92653
    United States Of America
    Director
    25261 Vealsquez Road
    Laguna Hills
    Ca 92653
    United States Of America
    American79391960001
    WILLIAMS, Kevin Donald
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    Director
    Unit 1 & 2 Heol Rhosyn
    Parc Dafen
    SA14 8QG Llanelli
    Carmarthenshire
    WalesWelsh122167440001
    WOOLMAN, Paul
    Foxhill Farm
    Broad Haven
    SA62 3TY Haverfordwest
    Dyfed
    Director
    Foxhill Farm
    Broad Haven
    SA62 3TY Haverfordwest
    Dyfed
    WalesBritish34870340001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene CGX REALISATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 09 oct 2014
    Entregado el 23 oct 2014
    Pendiente
    Breve descripción
    Land "the beacon" at unuts 4, 5 & 6 llanelli gate house, dafen, llanelli. Patent entitled "laser depilation" with grant number 0732895. please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Squadron Capital Llc
    Transacciones
    • 23 oct 2014Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 28 feb 2014
    Entregado el 18 mar 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Finance Wales Investments (3) LTD
    Transacciones
    • 18 mar 2014Registro de una carga (MR01)
    • 16 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 15 jun 2011
    Entregado el 16 jun 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jun 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 16 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 09 mar 2011
    Entregado el 22 mar 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Finance Wales Investments (6) Limited
    Transacciones
    • 22 mar 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 16 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 28 sept 2010
    Entregado el 29 sept 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re chromogenex technologies limited and numbered 03760913 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 29 sept 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 16 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    All assets debenture
    Creado el 30 abr 2010
    Entregado el 05 may 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 05 may 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 16 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 24 oct 2007
    Entregado el 07 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 07 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 08 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 26 mar 1998
    Entregado el 09 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mehl Biophile International Corporation
    Transacciones
    • 09 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 15 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment and charge of copyright and design right
    Creado el 13 jul 1995
    Entregado el 24 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The copyrights being :- chromos lasers - multiple beam thermolysis laser and laser for treatment of vascular lesions sirius lasers being - carbon dioxide (C02) medical lasers k/a :- the sirius 200 and the sirius 300 and the sirius 500. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 06 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of patents
    Creado el 13 jul 1995
    Entregado el 24 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The applications for patents :- UK multiple beam thermolysis laser 9420696.8 1994 UK laser for treatment of vascular lesions 9420532.5 1994. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 06 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 ago 1993
    Entregado el 01 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 01 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 06 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 mar 1993
    Entregado el 23 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 23 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 06 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 05 sept 1989
    Adquirido el 06 nov 1992
    Entregado el 20 nov 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due to the chargee under a secured loan agreement dated 5 september 1989
    Breve descripción
    All the copyright in the works throughout the world for the full period thereof (for full details of charge see from 395 and contd sheets).
    Personas con derecho
    • Welsh Development Agency
    Transacciones
    • 20 nov 1992Registro de una adquisición (400)
    • 27 ago 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CGX REALISATIONS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    11 sept 1998Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    09 jun 2000Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Gary Stones
    63 Walter Road
    SA1 4PT Swansea
    West Glamorgan
    Profesional
    63 Walter Road
    SA1 4PT Swansea
    West Glamorgan
    2
    FechaTipo
    09 dic 2015Inicio de la administración
    04 jul 2018Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Alistair Gareth Wardell
    Grant Thornton Uk Llp
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff
    Nigel Morrison
    Hartwell House, 55-61 Victoria Street
    BS1 6FT Bristol
    Profesional
    Hartwell House, 55-61 Victoria Street
    BS1 6FT Bristol

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0