HOLOGIC LTD.
Visión general
Nombre de la empresa | HOLOGIC LTD. |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02722343 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HOLOGIC LTD.?
- fabricación de productos farmacéuticos básicos (21100) / Industrias manufactureras
- Otras investigaciones y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería (72190) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra HOLOGIC LTD.?
Dirección de la sede social | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HOLOGIC LTD.?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
GEN-PROBE LIFE SCIENCES LTD. | 15 abr 2009 | 15 abr 2009 |
TEPNEL DIAGNOSTICS PLC | 18 ago 1992 | 18 ago 1992 |
FARAS DIAGNOSTICS PLC | 11 jun 1992 | 11 jun 1992 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HOLOGIC LTD.?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HOLOGIC LTD.?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 abr 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 05 may 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 abr 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOLOGIC LTD.?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Michelangelo Stefani el 01 jun 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Jan Valeer Verstreken como director el 04 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2023 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cancelación total de la carga 027223430008 | 1 páginas | MR04 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2022 | 34 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2021 | 35 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Joseph John Kisby como secretario el 11 mar 2022 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Joseph John Kisby como director el 11 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Tanja Lynaire Brycker como director el 18 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew Lee Chard como director el 18 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew Lee Chard como secretario el 18 feb 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2020 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Ms Tanja Lynaire Brycker como director el 05 may 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Andrew Lee Chard como director el 05 may 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Andrew Lee Chard como secretario el 05 may 2020 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de John Joseph O'shea como director el 05 may 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de John Joseph O'shea como secretario el 05 may 2020 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Registro de la carga 027223430008, creada el 06 mar 2020 | 4 páginas | MR01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2019 | 26 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Jan Valeer Verstreken el 01 jun 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HOLOGIC LTD.?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISBY, Joseph John | Secretario | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | 293897260001 | |||||||
KISBY, Joseph John | Director | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | United Kingdom | British | Director | 293897130001 | ||||
STEFANI, Michelangelo | Director | Building Caprese 8th Floor Da Vincilaan 5 1935 Zaventem Corporate Village Belgium | Switzerland | Italian | International Counsel | 218188130010 | ||||
CHARD, Andrew Lee | Secretario | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | 269562160001 | |||||||
CRAIG, Ian Alexander, Mr | Secretario | The Quinta Beechfield Road SK9 7AU Alderley Edge Cheshire | British | 17019070002 | ||||||
CRAIG, Ian Alexander, Mr | Secretario | The Quinta Beechfield Road SK9 7AU Alderley Edge Cheshire | British | Solicitor | 17019070002 | |||||
FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip | Secretario | Crossfield House Aston By Budworth CW9 6NG Northwich Cheshire | British | Chartered Accountant | 79348050002 | |||||
GREENHALGH, Andrew Stephen Paul | Secretario | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | British | 151113210001 | ||||||
LEE, Jeremy Stephen William | Secretario | 10 Hodge Fold SK14 6BL Broadbottom Cheshire | British | 98814590001 | ||||||
O'SHEA, John Joseph | Secretario | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | 241505660001 | |||||||
SALKIN, Daniel | Secretario | Crewe Road Wythenshawe M23 9HZ Manchester Heron House Oak Business Park | British | 190732940001 | ||||||
SLATER, Michael Keith | Secretario | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | British | Group Finance Director | 127520220001 | |||||
WARBURTON, Anthony | Secretario | Ashfields Leigh Sinton WR13 5DH Malvern | British | 22545650001 | ||||||
BERRENDORF, Hans Michael Herbert | Director | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | Germany | German | Vp Europe | 150998950001 | ||||
BILLINGHAM, Michael Dennis | Director | Brownhills Cottage Brownhills Road CW6 9BQ Rushton Tarporley Cheshire | British | Commercial | 58322080002 | |||||
BOWEN, Robert William | Director | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | United States | American | Senior Vp General Counsel Secretary | 92112170002 | ||||
BRYCKER, Tanja Lynaire | Director | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | United Kingdom | Australian | Vice President Eu North | 269599480001 | ||||
CAMPBELL, John | Director | 1905 Mulsanne Dr 46077 Zionsville Indiana Usa | British | Business Executive | 46873770001 | |||||
CASEY, Mark Joseph | Director | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | Usa | American | Senior Vp, Chief Admin Officer, General Counsel | 176556400001 | ||||
CHARD, Andrew Lee | Director | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | England | British | Senior Director Emea Accounting | 192298760001 | ||||
CLARK, Andrew John Matthew | Director | Dears End Farm 51 Park Lane SG3 6PH Knebworth Hertfordshire | England | British | Consultant | 105881430001 | ||||
COLLEY, Terence | Director | 45 Park Lane DY12 2EU Bewdley Worcestershire | British | Businessman | 3802520001 | |||||
CRAIG, Ian Alexander, Mr | Director | The Quinta Beechfield Road SK9 7AU Alderley Edge Cheshire | England | British | Solicitor | 17019070002 | ||||
DOUGLAS, Simon Gordon, Dr | Director | 19 Aylesbury Close WA16 8AE Knutsford Cheshire | England | British | Business Development | 114475090001 | ||||
EGSTRAND, Claus | Director | Napier Way RH10 9RA Crawley Unit A2, Link 10 West Sussex United Kingdom | England | Danish | Group President | 174690510001 | ||||
FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip | Director | Crossfield House Aston By Budworth CW9 6NG Northwich Cheshire | England | British | Chartered Accountant | 79348050002 | ||||
HARDING, David Paul | Director | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | Usa | American | Senior Vp, General Manager International | 149831430001 | ||||
HATTON, Andrew Keith | Director | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | England | British | Director | 194206480001 | ||||
HEYNEN, Ian | Director | Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Heron House Manchester United Kingdom | Vp, Finance International, Divisional President/Gm | Canada | Vp, Finance International, Divisional President/Gm | 206829850001 | ||||
HIGHFIELD, Peter Edmund, Dr | Director | Iona 28 Hollin Lane Styal SK9 4JH Wilmslow Cheshire | British | Technical Director | 44440070002 | |||||
HULL, Carl William | Director | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | Usa | United States | President And Ceo | 137821960001 | ||||
IBERT, Hilja, Dr | Director | c/o Hologic Deutschland Gmbh Ring 15 65205 Wiesbaden Otto Von Guericke Germany | Germany | German | Vp & Gm Europe | 183570310001 | ||||
LEE, Jeremy Stephen William | Director | 10 Hodge Fold SK14 6BL Broadbottom Cheshire | United Kingdom | British | Financial Director | 98814590001 | ||||
LESAGE, Antoine Leon | Director | Heron House Oaks Business Park Crewe Road M23 9HZ Wythenshawe Manchester | Belgium | Belgium | Vp, Assistant General Counsel, International | 176558770001 | ||||
MADDEN, Christopher John Frank | Director | Tall Trees Chipstead Lane Chipstead TN13 2RF Sevenoaks Kent | British | Director | 33509140001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HOLOGIC LTD.?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hologic Inc | 06 abr 2016 | 250 Campus Drive MA 01752 Marlborough Hologic Inc Headquarter United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene HOLOGIC LTD. alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 06 mar 2020 Entregado el 09 mar 2020 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción All and whole the subjects at appleton place, appleton parkway, livingston being the whole subjects registered in the land register of scotland under title numbers WLN37029 and WLN41771. Contiene una promesa negativa: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Standard security | Creado el 19 dic 2008 Entregado el 04 feb 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The area or piece of ground lying to the south of appleton parkway, eliburn, livingston, west lothian t/no WLN37029 see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Standard security | Creado el 19 dic 2008 Entregado el 22 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 0.92 hectares lying to the south of appleton parkway eliburn livingston west lothian. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Standard security | Creado el 19 dic 2008 Entregado el 23 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Ground lying to the south of appleton parkway eliburn livingston west lothian t/n WLN37029. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 12 jun 2007 Entregado el 21 jun 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Assignment of intellectual property rights | Creado el 10 ene 2000 Entregado el 14 ene 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan facility letter dated 8TH december 1999 in respect of a loan facility of up to £2,200,000 | |
Breve descripción All the company's right title and interest to its intellectual property rights; all the company's rights of action in respect of its intellectual property rights. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Instrument constituting 5% convertible secured loan notes 2002 | Creado el 10 ago 1999 Entregado el 11 ago 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £250,000 due from the company to the chargee | |
Breve descripción £250000 deposit. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of deposit | Creado el 08 abr 1998 Entregado el 20 abr 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The due and prompt performance of the covenants and warranties due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 8TH april 1998 and/or this deed | |
Breve descripción The tenant charges its interest in the deposit sum being £19,500. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0