LONGWALL INTERNATIONAL LIMITED

LONGWALL INTERNATIONAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLONGWALL INTERNATIONAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02738310
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LONGWALL INTERNATIONAL LIMITED?

    • (2924) /

    ¿Dónde se encuentra LONGWALL INTERNATIONAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3rd Floor 9 Colmore Row
    B3 2BJ Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LONGWALL INTERNATIONAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JOY MINING MACHINERY LIMITED28 mar 199628 mar 1996
    LONGWALL INTERNATIONAL LIMITED13 ene 199313 ene 1993
    INTERNATIONAL MINING EQUIPMENT LIMITED17 dic 199217 dic 1992
    DMWSL 111 LIMITED07 ago 199207 ago 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LONGWALL INTERNATIONAL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 oct 2010

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para LONGWALL INTERNATIONAL LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LONGWALL INTERNATIONAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    12 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Marmion House 3 Copenhagen Street Worcester WR1 2HB a 3rd Floor 9 Colmore Row Birmingham B3 2BJ el 12 ene 2016

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Cese del nombramiento de Michael Nicholas Mannion como director el 24 jun 2015

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Barend Jakobus Van Der Westhuizen como director el 24 jun 2015

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Gerard Keenan como director el 24 jun 2015

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Wayne Kisten como director el 24 jun 2015

    2 páginasTM01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Restauración por orden judicial

    2 páginasAC92

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    5 páginas4.71

    Declaración de solvencia

    7 páginas4.70

    Domicilio social registrado cambiado de * Bromyard Road Worcester WR2 5EG* el 18 jun 2012

    2 páginasAD01

    Resolución de insolvencia

    Resolution insolvency:extraordinary resolution ;- "in specie"
    1 páginasLIQ MISC RES

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Cambio de datos del secretario Miss Catherine Leith el 24 jun 2011

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 07 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 jun 2011

    Estado de capital el 16 jun 2011

    • Capital: GBP 7,762,734.56
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Michael Nicholas Mannion el 16 jun 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 oct 2010

    4 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 oct 2009

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Michael Nicholas Mannion el 02 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Wayne Kisten el 02 nov 2009

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de LONGWALL INTERNATIONAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HODGETTS, Catherine
    Bromyard Road
    Worcester
    WR2 5EG
    Secretario
    Bromyard Road
    Worcester
    WR2 5EG
    BritishInternal Control Co-Ordinator134612370012
    VAN DER WESTHUIZEN, Barend Jakobus
    c/o Joy Global (Uk) Limited
    Bromyard Road
    St Johns
    WR2 5EG Worcester
    England
    Director
    c/o Joy Global (Uk) Limited
    Bromyard Road
    St Johns
    WR2 5EG Worcester
    England
    EnglandSouth AfricanDirector168726060002
    CARPENTER, David Noel Arthur
    East Folly
    Gretton Road Gotherington
    GL52 4QY Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    East Folly
    Gretton Road Gotherington
    GL52 4QY Cheltenham
    Gloucestershire
    British2438120001
    MAHMOOD, Tariq
    23 Cedar Avenue
    SK15 3GD Stalybridge
    Cheshire
    Secretario
    23 Cedar Avenue
    SK15 3GD Stalybridge
    Cheshire
    BritishAccountant108366970001
    RICHARDSON, Keith John
    17 Ilkeston Drive
    Aspull
    WN2 1QZ Wigan
    Secretario
    17 Ilkeston Drive
    Aspull
    WN2 1QZ Wigan
    British47835670001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    ABELL, John Norman
    Whittonditch House
    Ramsbury
    SN8 2PZ Marlborough
    Wiltshire
    Director
    Whittonditch House
    Ramsbury
    SN8 2PZ Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Director26918460002
    ANDREWS, William George
    Two Acres Cottage Middleton Road
    GU15 3TT Camberley
    Surrey
    Director
    Two Acres Cottage Middleton Road
    GU15 3TT Camberley
    Surrey
    BritishCompany Director58542770001
    BAILEY, Ian
    6 Marus Avenue
    Marus Bridge
    WN3 5QR Wigan
    Director
    6 Marus Avenue
    Marus Bridge
    WN3 5QR Wigan
    EnglishDirector52425340002
    BARRON, Michael John
    15 Oakdene Road
    TN13 3HH Sevenoaks
    Kent
    Director designado
    15 Oakdene Road
    TN13 3HH Sevenoaks
    Kent
    British900007620001
    BUCKMASTER, Adrian Charles
    The Close Holdfast
    Upton Upon Severn
    WR8 0QZ Worcester
    Director
    The Close Holdfast
    Upton Upon Severn
    WR8 0QZ Worcester
    EnglandBritishEngineer56273950001
    CHAPPLE, Oliver John
    Heather Lodge
    Upper Milton
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Director
    Heather Lodge
    Upper Milton
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector95217990001
    CORBY, Francis Michael
    18960 Alta Vista Drive
    Brookfield
    Wisconsin Wi 53045-4885
    Usa
    Director
    18960 Alta Vista Drive
    Brookfield
    Wisconsin Wi 53045-4885
    Usa
    AmericanExecutive Vice President44507660001
    COTTERILL, Roy Clifford George
    102 Evesham Road
    GL52 2AL Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    102 Evesham Road
    GL52 2AL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director1540920001
    HANSON, John Nils
    4015 West Canterbury Court
    WI 53092 Mequon
    Wisconsin
    Usa
    Director
    4015 West Canterbury Court
    WI 53092 Mequon
    Wisconsin
    Usa
    AmericanExecutive Vice President45718750001
    HARDING, Peter
    Bungalow
    Low Road
    DN10 6AG Scrooby
    New Farm
    South Yorkshire
    Director
    Bungalow
    Low Road
    DN10 6AG Scrooby
    New Farm
    South Yorkshire
    EnglandBritishCommercial Director3743800002
    HOLLAND, Charles John
    108 Wigan Road
    Ashton In Makerfield
    WN4 9SU Wigan
    Lancashire
    Director
    108 Wigan Road
    Ashton In Makerfield
    WN4 9SU Wigan
    Lancashire
    BritishCompany Director29712870001
    JOHNSON, Arthur David
    Rufford Lodge
    Rufford Abbey Park
    NG22 9DE Ollerton Newark
    Nottinghamshire
    Director
    Rufford Lodge
    Rufford Abbey Park
    NG22 9DE Ollerton Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompany Director1150990001
    KAYE, Alan
    Mill Hill Farm Mill Lane
    Goosnargh
    PR3 2JX Preston
    Lancashire
    Director
    Mill Hill Farm Mill Lane
    Goosnargh
    PR3 2JX Preston
    Lancashire
    BritishDirector11423740001
    KEENAN, Gerard
    Seaman Way
    Ince
    WN2 2LE Wigan
    Wigan Enterprise Park
    Lancashire
    England
    Director
    Seaman Way
    Ince
    WN2 2LE Wigan
    Wigan Enterprise Park
    Lancashire
    England
    United KingdomBritishAssistant Treasurer80800810001
    KENNEDY, Brian
    19 Tower Hill Road
    Upholland
    WN8 0DU Wigan
    Lancashire
    Director
    19 Tower Hill Road
    Upholland
    WN8 0DU Wigan
    Lancashire
    BritishCompany Director34236350001
    KISTEN, Wayne
    Copenhagen Street
    WR1 2HB Worcester
    Marmion House 3
    Director
    Copenhagen Street
    WR1 2HB Worcester
    Marmion House 3
    United KingdomSouth AfricanFinance Director124137710002
    MANNION, Michael Nicholas
    Kirkby Lane
    Pinxton
    NG16 6HX Nottingham
    Sales And Service Centre
    United Kingdom
    Director
    Kirkby Lane
    Pinxton
    NG16 6HX Nottingham
    Sales And Service Centre
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director160671010001
    MARTIN, Alan Graham
    12 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Middlesex
    Director designado
    12 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Middlesex
    British900007610001
    PARSONS, Howard Robert
    Briar House
    Church Lane
    WR7 4RS Stoulton Pershore
    Worcestershire
    Director
    Briar House
    Church Lane
    WR7 4RS Stoulton Pershore
    Worcestershire
    BritishChartered Accounytant108355830001
    POWELL, George Christopher James
    16 Wellington Square
    GL50 4JS Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    16 Wellington Square
    GL50 4JS Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant71388200001
    REID, William J
    9 Yorkshire
    Middlebrook
    TN 37620 Bristol
    Usa
    Director
    9 Yorkshire
    Middlebrook
    TN 37620 Bristol
    Usa
    BritishDirector34113720001
    RICHARDSON, Keith John
    17 Ilkeston Drive
    Aspull
    WN2 1QZ Wigan
    Director
    17 Ilkeston Drive
    Aspull
    WN2 1QZ Wigan
    BritishFinancial Controller47835670001
    ROONEY, Gerard
    354 Oakmount Drive
    Abingdon Virginia 24210
    Usa
    Director
    354 Oakmount Drive
    Abingdon Virginia 24210
    Usa
    BritishDirector18080080001
    TAYLOR, Anthony Christopher
    Wynfrith 8 Church Avenue
    Penwortham
    PR1 0AH Preston
    Lancashire
    Director
    Wynfrith 8 Church Avenue
    Penwortham
    PR1 0AH Preston
    Lancashire
    EnglandBritishDirector36136250001
    WALKER, John Hirst
    25 Hallside Park
    WA16 6BP Knutsford
    Cheshire
    Director
    25 Hallside Park
    WA16 6BP Knutsford
    Cheshire
    BritishDirector1176150003

    ¿Tiene LONGWALL INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture between the company and the law debenture trust corporation PLC (the "security trustee")
    Creado el 05 jul 2001
    Entregado el 12 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to any finance party (as defined) on any account whatsoever under or in connection with any finance document (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 12 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 15 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creado el 22 mar 2001
    Entregado el 02 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future moneys, debts and liabilities due, owing or incurred by each chargor to any financing party on any acount whatsoever under or in connection with any finance document
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 02 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 24 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 22 feb 1993
    Entregado el 26 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due from each obligor to the chargee under the financing documents
    Breve descripción
    F/H land and buildings at pinxton green pinxton notts t/nos. NT121318 and nt 82716. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 mar 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene LONGWALL INTERNATIONAL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 may 2012Inicio de la liquidación
    01 sept 2016Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Gilbert J Lemon
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    Profesional
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    Neil Francis Hickling
    Marmion House 3 Copenhagen Street
    WR1 2HB Worcester
    Profesional
    Marmion House 3 Copenhagen Street
    WR1 2HB Worcester
    Andrew Stephen Mcgill
    3rd Floor, 9 Colmore Row
    B3 2BJ Birmingham
    Profesional
    3rd Floor, 9 Colmore Row
    B3 2BJ Birmingham
    Gilbert J Lemon
    3rd Floor 9 Colmore Row
    B3 2BJ Birmingham
    Profesional
    3rd Floor 9 Colmore Row
    B3 2BJ Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0