JETBLOOM LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | JETBLOOM LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02739830 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de JETBLOOM LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra JETBLOOM LIMITED?
Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de JETBLOOM LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para JETBLOOM LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital el 02 sept 2022
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gavin Bergin como director el 04 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Amanda Jane Jones como director el 29 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nick Taunt como director el 29 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Charles John Middleton como director el 31 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Amanda Jane Jones como director el 18 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Bruce Michael James como director el 31 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gavin Bergin como director el 29 mar 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nick Taunt como director el 05 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tom Robson como director el 11 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Josephine Hayman como director el 31 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Tom Robson como director el 31 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de JETBLOOM LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
HAYMAN, Josephine | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 266797860001 | ||||||||
MCNUFF, Jonathan Charles | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 205624050001 | ||||||||
COOK, Kenneth Alan | Secretario | 27 Glendower Road East Sheen SW14 8NY London | British | Accountant | 100000003 | |||||||||
GARSON, Michael David | Secretario | 2 Gabrielle Court Lancaster Grove NW3 4EU London | British | 38643490001 | ||||||||||
HODGES, Philip James | Secretario | 110 Cinques Road Gamlingay SG19 3NR Sandy Bedfordshire | British | 38646400001 | ||||||||||
MARTIN, Philip John | Secretario | Runwick Hill Runwick Lane GU10 5EE Farnham Surrey | British | 35118050001 | ||||||||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
BERESFORD, Valentine Tristram | Director | 3 Smith Terrace SW3 4DL London | England | British | Company Director | 40766290003 | ||||||||
BERGIN, Gavin | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 251327820001 | ||||||||
BOSSOM, Bruce Charles | Director | Overbury Court GL20 7NP Tewkesbury Gloucestershire | United Kingdom | British | Company Director | 32773150001 | ||||||||
DOWNS, Phillip Langford | Director | 61 Outerwyke Road PO22 8LT Bognor Regis West Sussex | British | Accountant | 56910100001 | |||||||||
GROSE, Benjamin Toby | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||||||
HARRIS, David Anthony | Director | 2 Challoners Close Rottingdean BN2 7DG Brighton Sussex | England | British | Accountant | 36536220001 | ||||||||
JAMES, Bruce Michael | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Head Of Secretariat | 226746900001 | ||||||||
JONES, Alan Michael | Director | 37 King George Square TW10 6LF Richmond Surrey | British | Solicitor | 74175140001 | |||||||||
JONES, Amanda Jane | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 73507000004 | ||||||||
JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||||||
MARTIN, Philip John | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 35118050001 | ||||||||
MCGANN, Martin Francis | Director | 10 Westcombe Park Road SE3 7RB Blackheath London | British | Chartered Accountant | 109383240001 | |||||||||
MIDDLETON, Charles John | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Tax Executive | 79841030002 | ||||||||
MOULD, Harold Raymond | Director | 40 Hasker Street SW3 2LQ London | England | British | Solicitor | 35576350006 | ||||||||
PRICE, Humphrey James Montgomery | Director | Deaks Deaks Lane RH17 5JA Cuckfield West Sussex | Uk | British | Chartered Accountant | 14448630001 | ||||||||
RICHARDS, Martin Edgar | Director designado | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||||||
ROBSON, Tom | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Financial Accountant | 266793650001 | ||||||||
SCHNEIDERMAN, Robert | Director | 20 Farrington Street EC4A 4PP London | British | 32890090001 | ||||||||||
SMITH, Andrew David | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Surveyor | 108214880002 | ||||||||
STIRLING, Mark Andrew | Director | Great Oak House Essendon Place, Essendon AL9 6GZ Hatfield Hertfordshire | United Kingdom | British | Surveyor | 106882210001 | ||||||||
TAUNT, Nick | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 275050860001 | ||||||||
TREHARNE, Stephen | Director | 730 PO BOX EC4A 4PP London | British | Accountant | 20331220001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de JETBLOOM LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pillar Property Group Limited | 06 abr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Pillar Property Group Limited | 06 abr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene JETBLOOM LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Charge | Creado el 16 mar 1998 Entregado el 01 abr 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each finance party under each finance document (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0