MEARS HOMECARE LIMITED

MEARS HOMECARE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMEARS HOMECARE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02744787
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MEARS HOMECARE LIMITED?

    • Actividades de las agencias de empleo temporal (78200) / Actividades administrativas y de apoyo
    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra MEARS HOMECARE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1390 Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MEARS HOMECARE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CARE UK HOMECARE LIMITED11 oct 200111 oct 2001
    HOMECARING LIMITED15 abr 199315 abr 1993
    FIT BITZ LIMITED03 sept 199203 sept 1992

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MEARS HOMECARE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MEARS HOMECARE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2022

    14 páginasAA

    legacy

    167 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Estado de capital el 03 abr 2023

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c and capital redemption reserve 27/03/2023
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2021

    14 páginasAA

    legacy

    171 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Mears Care (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jul 2021

    2 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2019

    26 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    25 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de MEARS HOMECARE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WESTRAN, Ben Robert
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    Secretario
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    198336280001
    SMITH, Andrew Christopher Melville
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    England
    Director
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    England
    EnglandBritish121328600001
    MEARS GROUP PLC
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    England
    Director corporativo
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro03232863
    149799340001
    BISHOP, Bryon
    Great Woodley Farm House
    Woodley Lane
    SO51 7PE Romsey
    Hampshire
    Secretario
    Great Woodley Farm House
    Woodley Lane
    SO51 7PE Romsey
    Hampshire
    British22786840001
    BOOKER, Roger Ian
    4 Southgate Gardens
    Long Melford
    CO10 9HB Sudbury
    Suffolk
    Secretario
    4 Southgate Gardens
    Long Melford
    CO10 9HB Sudbury
    Suffolk
    British14044530002
    CALOW, Jonathan David
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Secretario
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    165449440001
    GRIFFITHS, Freda Margaret
    2 Hiltingbury Road
    SO53 5SW Eastleigh
    Hampshire
    Secretario
    2 Hiltingbury Road
    SO53 5SW Eastleigh
    Hampshire
    British30316030001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Secretario
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    British33223550003
    CARE UK SERVICES LTD
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2482660
    125241530002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretario designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BENN, Geoffrey Richard
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    Director
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish73786580001
    BISHOP, Bryon
    Great Woodley Farm House
    Woodley Lane
    SO51 7PE Romsey
    Hampshire
    Director
    Great Woodley Farm House
    Woodley Lane
    SO51 7PE Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritish22786840001
    BOOKER, Roger Ian
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    Director
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish14044530003
    BOOKER, Roger Ian
    4 Southgate Gardens
    Long Melford
    CO10 9HB Sudbury
    Suffolk
    Director
    4 Southgate Gardens
    Long Melford
    CO10 9HB Sudbury
    Suffolk
    British14044530002
    BRYANT, James Richard Stansfeld
    Drapers Farmhouse
    Rushden
    SG9 0TB Buntingford
    Hertfordshire
    Director
    Drapers Farmhouse
    Rushden
    SG9 0TB Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish7897550001
    CLOUGH, Richard Stanley
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    Director
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    EnglandBritish7897560001
    CULHANE, Angela
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritish68602910001
    GRIFFITHS, Freda Margaret
    2 Hiltingbury Road
    SO53 5SW Eastleigh
    Hampshire
    Director
    2 Hiltingbury Road
    SO53 5SW Eastleigh
    Hampshire
    British30316030001
    HASTINGS, Roy
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    Director
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    United KingdomBritish130098430001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish33223550003
    MARRIOTT-LAVERY, Deborah Jane
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish151689670002
    PAGE, Jacalyn Frances
    15 Chessel Crescent
    Bitterne
    SO19 4BR Southampton
    Hampshire
    Director
    15 Chessel Crescent
    Bitterne
    SO19 4BR Southampton
    Hampshire
    British30316040001
    PARISH, Michael Robert
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritish78828750003
    QUINN, David Laurence, Mr.
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    Director
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish123356660001
    RUSSELL, Andrew Philip Thomas
    37 Woodley Lane
    SO51 7JL Romsey
    Hampshire
    Director
    37 Woodley Lane
    SO51 7JL Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish23099130001
    RUSSELL, Vivienne Patricia
    37 Woodley Lane
    SO51 7JL Romsey
    Hampshire
    Director
    37 Woodley Lane
    SO51 7JL Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish33748240001
    SCOTT, Christine Jennifer
    166 Bucklesham Road
    Purdis Farm
    IP3 8SW Ipswich
    Suffolk
    Director
    166 Bucklesham Road
    Purdis Farm
    IP3 8SW Ipswich
    Suffolk
    British24581020002
    UMBERS, Douglas
    SO53
    Director
    SO53
    United KingdomBritish90541690001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    Director
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    EnglandBritish130512090002
    WATSON, Paul John
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    England
    Director
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    England
    United KingdomBritish82460360003
    WEEKS, Catherine Jane
    8 Chancellery Mews
    Risbygate Street
    IP33 3AB Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Director
    8 Chancellery Mews
    Risbygate Street
    IP33 3AB Bury St. Edmunds
    Suffolk
    British72222500003
    WHITECROSS, Philip James
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Director
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritish193730760001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Director designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MEARS HOMECARE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Gloucester Business Park
    GL3 4AH Brockworth
    1390 Montpellier Court
    Gloucester
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Gloucester Business Park
    GL3 4AH Brockworth
    1390 Montpellier Court
    Gloucester
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03689426
    Naturaleza del control
    • La persona tiene derecho a ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una sociedad civil que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa sociedad civil (en esa calidad) poseen, directamente o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) poseen, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho de ejercer, o realmente ejercen, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene MEARS HOMECARE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 22 feb 2018
    Entregado el 22 feb 2018
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 22 feb 2018Registro de una carga (MR01)
    • 17 may 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 26 sept 2014
    Entregado el 30 sept 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company listed above charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transacciones
    • 30 sept 2014Registro de una carga (MR01)
    • 10 jun 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 22 dic 2011
    Entregado el 05 ene 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £3,671.88 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Its interest in the deposit account see image for full details.
    Personas con derecho
    • Newmarket General Partner Limited and Newmarket Nominee Limited
    Transacciones
    • 05 ene 2012Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 21 jul 2010
    Entregado el 26 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Transacciones
    • 26 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 24 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 12 feb 2009
    Entregado el 14 feb 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £3,671.88 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    With full title guarantee by way of fixed charge charges its interest in the deposit and all money from time to time withdrawn from the deposit in accordance with the rent deposit deed.
    Personas con derecho
    • Active Retail Rookery Fund (General Partner) Limited
    Transacciones
    • 14 feb 2009Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 10 ene 2006
    Entregado el 12 ene 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    £3,671.88 held in a deposit account.
    Personas con derecho
    • Active Retail Rookery Fund (General Partner) Limited
    Transacciones
    • 12 ene 2006Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 21 ene 2005
    Entregado el 26 ene 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £4,406.25 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The interest and all sums from time to time in a deposit account with the hsbc bank PLC.
    Personas con derecho
    • Daniela Julia Michal Rose Maier
    Transacciones
    • 26 ene 2005Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 02 jul 2004
    Entregado el 17 jul 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The sum of £8,250.00.
    Personas con derecho
    • James Godfrey Blenkin and Bronwen Mary Blenkin
    Transacciones
    • 17 jul 2004Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 30 mar 2000
    Entregado el 11 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to any beneficiary under or pursuant to the terms of any of the finance documents, the loan facility or other financial accommodation and under the terms of the charge (all defined therein)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland("the Security Trustee")
    Transacciones
    • 11 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 mar 2000
    Entregado el 10 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 21 ene 1999
    Entregado el 01 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 16 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 20 jul 1995
    Entregado el 26 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 16 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0